PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED
Panoramica
Nome della società | PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03204842 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1st Floor Health Aid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow Middlesex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
FAST TRACK NOMINEES (NO.3) LIMITED | 07 giu 1996 | 07 giu 1996 |
DEANFOREST LIMITED | 29 mag 1996 | 29 mag 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 10 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 24 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 10 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 30 set 2023 | 16 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2022 | 16 pagine | AA | ||
Nomina di Ms Laxmi Sivasubramanian come segretario in data 05 ago 2022 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Robert Jeffrey Piper come segretario in data 05 ago 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2021 | 15 pagine | AA | ||
Soddisfazione dell'onere 032048420017 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 032048420018 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 032048420019 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 032048420020 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 032048420021 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2020 | 12 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Allan Howard Kay come amministratore in data 01 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Rubins il 10 mag 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 032048420020, creata il 13 apr 2018 | 7 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 032048420021, creata il 13 apr 2018 | 7 pagine | MR01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 12 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVASUBRAMANIAN, Laxmi | Segretario | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | 299635790001 | |||||||
KAY, Allan Howard | Amministratore | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | England | British | Director | 51275610001 | ||||
MELLER, Stephen Daniel | Amministratore | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | England | British | Finance Broker | 70938260003 | ||||
RUBINS, Brian Leslie | Amministratore | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex United Kingdom | England | British | Company Director | 95281890005 | ||||
RUBINS, Jonathan | Amministratore | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | England | British | Company Director | 118928320001 | ||||
FISK, Claire | Segretario | 7 Baldock Road SG6 3LB Letchworth Hertfordshire | British | 121524350001 | ||||||
KEEN, Frances Betty | Segretario | 9 Springfield Road NW8 0QJ London | British | 10151630001 | ||||||
NYKERK, Gerald David | Segretario | 44 St Clements Drive SS9 3BJ Leigh On Sea Essex | British | 17761620001 | ||||||
PIPER, Robert Jeffrey | Segretario | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | British | 95275260001 | ||||||
RUBINS, Jonathan | Segretario | 5 Manor Close SG6 3NN Letchworth Garden City Hertfordshire | British | 118928320001 | ||||||
WOOD, Maurice Thomas | Segretario | 10 Wellington Court Shelton Street WC2H 9JS London | British | 32560410001 | ||||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
SOUTHERN FUNDING LIMITED | Segretario | 94-96 Wigmore Street W1U 3RQ London | 47608700002 | |||||||
KEEN, Howard Ramon | Amministratore | Bessemer Drive SG1 2DX Stevenage Business And Technology Centre, Suite F8 Hertfordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 35540650005 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative Bridging Corporation Limited | 06 apr 2016 | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 13 apr 2018 Consegnato il 16 apr 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 apr 2018 Consegnato il 16 apr 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 29 set 2015 Consegnato il 07 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 29 set 2015 Consegnato il 07 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 29 set 2015 Consegnato il 07 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-charge | Creato il 01 apr 2011 Consegnato il 15 apr 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A mortgage of the property k/a 1 azure court doxford park sunderland and all principal interest or other money now and in the future secured by the mortgage together with the benefit of any other security now and in the future held for some indebtedness. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-mortgage | Creato il 02 lug 2003 Consegnato il 16 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,600,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land and buildings on the south west side of mirabel street, cheetham, manchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-charge | Creato il 20 giu 2003 Consegnato il 01 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £229,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 22 college road (formerly k/a land and buildings on the north side of college road) cheshunt, hertfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-mortgage | Creato il 07 dic 2001 Consegnato il 19 dic 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property known as 5 broomleigh, booth road, altrincham, cheshire and garage. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub charge | Creato il 27 ott 2001 Consegnato il 31 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £261,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Charge dated 27TH october 2001 relating to 24 petersham place london SW7. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Subcharge | Creato il 15 ago 2001 Consegnato il 01 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £259,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Charge dated 15 august 2001 relating to 18/21 kings park road southampton t/no: HP104413. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-mortgage | Creato il 06 giu 2000 Consegnato il 15 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 5 st johns villas marloes road W8 and parking space 194 and 195 marloes road W8. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-charge | Creato il 10 nov 1999 Consegnato il 19 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £500,000 due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 14TH june 1999 | |
Brevi particolari Units 17 & 18 octavian way team valley gateshead. Units 21 & 22 park view industrial estate hartlepool. Units 7-26 kingsway team valley gateshead. Viscount house queensway enterprise estate scunthorpe. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-charge | Creato il 08 ott 1999 Consegnato il 15 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 17TH september 1999 | |
Brevi particolari Flat 75 william court 6 hall road london NW8. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-charge | Creato il 07 set 1999 Consegnato il 18 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £56,700 due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 3 march 1999 | |
Brevi particolari Hereby charge the charge dated with even date herewith and the principal monies secured by that charge and all interest upon it due or about to become due and the benefit of all securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 15 lug 1999 Consegnato il 30 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £29,400.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter 3 march 1998 | |
Brevi particolari The property known as 40 thackeray avenue, tottenham london N17. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 25 mag 1999 Consegnato il 10 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £65,100 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 209 ribblesdale road SW16 6QS was charged by a charge dated 25/5/99. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed | Creato il 19 apr 1999 Consegnato il 30 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £504,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Legal charge dated 19TH april 1999 relating to property at 493, 495, 497 & 499 watford way mill hill l/b of barnet. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub charge | Creato il 16 apr 1998 Consegnato il 22 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal sum of £450,000 together with interest due or to become due from the company to the chargee in accordance with thefacility letter dated 27/02/98 | |
Brevi particolari The charge dated 16/04/98 and the principal monies secured by that charge and all interest due upon it and the benefit of all securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub charge | Creato il 23 mar 1998 Consegnato il 27 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £165,900 due from the company to the chargee in accordance with the facility letter dated 27TH february 1998 from the lender to the company together with interest thereon | |
Brevi particolari The charge dated 23RD march 1998 and the principal monies secured by that charge and all interest due or to become due upon it and the benefit of all securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 mar 1998 Consegnato il 17 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0