PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED

PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03204842
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor Health Aid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAST TRACK NOMINEES (NO.3) LIMITED07 giu 199607 giu 1996
    DEANFOREST LIMITED29 mag 199629 mag 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma24 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 30 set 2023

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2022

    16 pagineAA

    Nomina di Ms Laxmi Sivasubramanian come segretario in data 05 ago 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Robert Jeffrey Piper come segretario in data 05 ago 2022

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2021

    15 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 032048420017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032048420018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032048420019 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032048420020 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032048420021 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Allan Howard Kay come amministratore in data 01 set 2020

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Rubins il 10 mag 2018

    2 pagineCH01

    Iscrizione dell'ipoteca 032048420020, creata il 13 apr 2018

    7 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 032048420021, creata il 13 apr 2018

    7 pagineMR01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SIVASUBRAMANIAN, Laxmi
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    Segretario
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    299635790001
    KAY, Allan Howard
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector51275610001
    MELLER, Stephen Daniel
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    EnglandBritishFinance Broker70938260003
    RUBINS, Brian Leslie
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director95281890005
    RUBINS, Jonathan
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director118928320001
    FISK, Claire
    7 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    7 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    British121524350001
    KEEN, Frances Betty
    9 Springfield Road
    NW8 0QJ London
    Segretario
    9 Springfield Road
    NW8 0QJ London
    British10151630001
    NYKERK, Gerald David
    44 St Clements Drive
    SS9 3BJ Leigh On Sea
    Essex
    Segretario
    44 St Clements Drive
    SS9 3BJ Leigh On Sea
    Essex
    British17761620001
    PIPER, Robert Jeffrey
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    Segretario
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    England
    British95275260001
    RUBINS, Jonathan
    5 Manor Close
    SG6 3NN Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Manor Close
    SG6 3NN Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    British118928320001
    WOOD, Maurice Thomas
    10 Wellington Court
    Shelton Street
    WC2H 9JS London
    Segretario
    10 Wellington Court
    Shelton Street
    WC2H 9JS London
    British32560410001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    SOUTHERN FUNDING LIMITED
    94-96 Wigmore Street
    W1U 3RQ London
    Segretario
    94-96 Wigmore Street
    W1U 3RQ London
    47608700002
    KEEN, Howard Ramon
    Bessemer Drive
    SG1 2DX Stevenage
    Business And Technology Centre, Suite F8
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bessemer Drive
    SG1 2DX Stevenage
    Business And Technology Centre, Suite F8
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSolicitor35540650005
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Healthaid House
    Marlborough Hill
    HA1 1UD Harrow
    1st Floor
    Middlesex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07194858
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 apr 2018
    Consegnato il 16 apr 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Topland Jupiter Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 apr 2018
    Consegnato il 16 apr 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Topland Jupiter Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 set 2015
    Consegnato il 07 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Topland Jupiter Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 set 2015
    Consegnato il 07 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Topland Jupiter Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 set 2015
    Consegnato il 07 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Topland Jupiter Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 15 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A mortgage of the property k/a 1 azure court doxford park sunderland and all principal interest or other money now and in the future secured by the mortgage together with the benefit of any other security now and in the future held for some indebtedness.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub-mortgage
    Creato il 02 lug 2003
    Consegnato il 16 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,600,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south west side of mirabel street, cheetham, manchester.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 16 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sub-charge
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 01 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £229,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    22 college road (formerly k/a land and buildings on the north side of college road) cheshunt, hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 01 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub-mortgage
    Creato il 07 dic 2001
    Consegnato il 19 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 5 broomleigh, booth road, altrincham, cheshire and garage.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 19 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub charge
    Creato il 27 ott 2001
    Consegnato il 31 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £261,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Charge dated 27TH october 2001 relating to 24 petersham place london SW7.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 31 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Subcharge
    Creato il 15 ago 2001
    Consegnato il 01 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £259,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Charge dated 15 august 2001 relating to 18/21 kings park road southampton t/no: HP104413.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 01 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub-mortgage
    Creato il 06 giu 2000
    Consegnato il 15 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5 st johns villas marloes road W8 and parking space 194 and 195 marloes road W8.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 15 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub-charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 19 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 14TH june 1999
    Brevi particolari
    Units 17 & 18 octavian way team valley gateshead. Units 21 & 22 park view industrial estate hartlepool. Units 7-26 kingsway team valley gateshead. Viscount house queensway enterprise estate scunthorpe.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank
    Transazioni
    • 19 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub-charge
    Creato il 08 ott 1999
    Consegnato il 15 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 17TH september 1999
    Brevi particolari
    Flat 75 william court 6 hall road london NW8.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank
    Transazioni
    • 15 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub-charge
    Creato il 07 set 1999
    Consegnato il 18 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £56,700 due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 3 march 1999
    Brevi particolari
    Hereby charge the charge dated with even date herewith and the principal monies secured by that charge and all interest upon it due or about to become due and the benefit of all securities.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 18 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 15 lug 1999
    Consegnato il 30 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £29,400.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter 3 march 1998
    Brevi particolari
    The property known as 40 thackeray avenue, tottenham london N17.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 30 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 10 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £65,100 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    209 ribblesdale road SW16 6QS was charged by a charge dated 25/5/99.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 10 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed
    Creato il 19 apr 1999
    Consegnato il 30 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £504,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Legal charge dated 19TH april 1999 relating to property at 493, 495, 497 & 499 watford way mill hill l/b of barnet.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 30 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub charge
    Creato il 16 apr 1998
    Consegnato il 22 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £450,000 together with interest due or to become due from the company to the chargee in accordance with thefacility letter dated 27/02/98
    Brevi particolari
    The charge dated 16/04/98 and the principal monies secured by that charge and all interest due upon it and the benefit of all securities.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrachi Bank Limited
    Transazioni
    • 22 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Sub charge
    Creato il 23 mar 1998
    Consegnato il 27 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £165,900 due from the company to the chargee in accordance with the facility letter dated 27TH february 1998 from the lender to the company together with interest thereon
    Brevi particolari
    The charge dated 23RD march 1998 and the principal monies secured by that charge and all interest due or to become due upon it and the benefit of all securities.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 27 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 mar 1998
    Consegnato il 17 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 17 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0