PETROCELTIC RESOURCES LIMITED

PETROCELTIC RESOURCES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPETROCELTIC RESOURCES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03210072
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor, 10 Finsbury Square
    EC2A 1AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PETROCELTIC RESOURCES PLC19 ago 201319 ago 2013
    MELROSE RESOURCES PLC08 apr 199808 apr 1998
    MELROSE PETROLEUM GROUP LIMITED 07 apr 199707 apr 1997
    MELROSE PETROLEUM V LIMITED10 giu 199610 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    12 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 032100720043 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032100720046 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2021 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 111 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 0SR England a 83 Victoria Street London SW1H 0HW

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    18 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Petroceltic Holdings Limited come persona con controllo significativo il 30 apr 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 032100720045 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032100720044 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 032100720046, creata il 12 mar 2020

    41 pagineMR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2nd Floor, Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS England a 111 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 0SR

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Angelo Radostinov Moskov il 21 giu 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Denis Ischenko il 21 giu 2019

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 032100720042 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10 Greycoat Place London SW1P 1SB a 2nd Floor, Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Joseph Lenihan Mulcahy come amministratore in data 06 set 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILSON, Peter
    Collessie
    KY15 7RQ Cupar
    Thirlestane House
    Scotland
    Segretario
    Collessie
    KY15 7RQ Cupar
    Thirlestane House
    Scotland
    214876960001
    ISCHENKO, Denis
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    Amministratore
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    EnglandBritish209523810001
    MOSKOV, Angelo Radostinov
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    Amministratore
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    United KingdomBritish158210200001
    LARSEN, Glynn Andrew
    55a Upper Montagu Street
    W1H 1FQ London
    Segretario
    55a Upper Montagu Street
    W1H 1FQ London
    British75432740003
    LOW, Sarah Rosemary Moir
    Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    19
    Midlothian
    United Kingdom
    Segretario
    Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    19
    Midlothian
    United Kingdom
    209425110001
    ROBINSON, Alasdair Nicholson
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Segretario
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    British99931280001
    THOMAS, Christopher Charles Arnold
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    Segretario
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    British45958770001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Segretario nominato
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    TODS MURRAY LLP
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    1117600003
    ADAIR, Robert Fredrik Martin
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish141849580002
    AGNEW, James Douglas
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish126602000001
    ARCHER, David Fraser
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish49699910001
    CAMERON, Henry Ogilvy
    20 Wellbrae Terrace
    AB15 7XY Aberdeen
    Scotland
    Amministratore
    20 Wellbrae Terrace
    AB15 7XY Aberdeen
    Scotland
    British179510001
    CURRY, David William
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    Amministratore
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    British57960560003
    FRASER, Diane Margaret Vivienne
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish192830550002
    HAY, James Taylor Cantlay
    67 Fountainhall Road
    AB2 4EU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    67 Fountainhall Road
    AB2 4EU Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1206020001
    HICKEY, Thomas Gerard
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    IrelandIrish74548640003
    HUDSON, Kelvin Mark
    Le Manoir
    Ruette Des Effards, Castel
    GY5 7DQ Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Le Manoir
    Ruette Des Effards, Castel
    GY5 7DQ Guernsey
    Channel Islands
    GuernseyBritish75788480001
    KEBAILI, Ahmed L, Dr
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    FranceAmerican131407160002
    LANE, George
    11e/1 Ravelston Park
    EH4 3DX Edinburgh
    Amministratore
    11e/1 Ravelston Park
    EH4 3DX Edinburgh
    British19070490001
    MULCAHY, Joseph Lenihan
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandIrish209520250001
    O'CATHAIN, Brian John
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Ireland (Republic Of)Irish172956350001
    PARSLEY, Alan John, Dr
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    EnglandBritish135195050002
    RICHMOND-WATSON, Anthony Euan
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish1467180001
    SUTHERLAND, James Munro Murray
    14 Braid Avenue
    EH10 6EE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    14 Braid Avenue
    EH10 6EE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish243360001
    THOMAS, Christopher Charles Arnold
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    Amministratore
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    British45958770001
    THOMAS, Christopher Charles Arnold
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    Amministratore
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    British45958770001
    THOMAS, David Howard
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish65462550002
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish1604580001
    WYATT, William Penfold
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    EnglandBritish87896480001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Amministratore delegato nominato
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PETROCELTIC RESOURCES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sunny Hill Energy Limited
    Greycoat Place
    SW1P 1SB London
    10
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Greycoat Place
    SW1P 1SB London
    10
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Cardiff
    Numero di registrazione9728547
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 mar 2020
    Consegnato il 16 mar 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold and leasehold property in england & wales as more fully set out in the definition of "real property" in clause 1. "intellectual property" means any patents, trademarks etc as more fully defined in clause 1.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ploutos Agency Llc (As Security Agent)
    Transazioni
    • 16 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 mar 2017
    Consegnato il 04 apr 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ploutos Agency Llc
    Transazioni
    • 04 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 mar 2017
    Consegnato il 04 apr 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ploutos Agency Llc
    Transazioni
    • 04 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 mar 2017
    Consegnato il 04 apr 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold and leasehold property in england and wales as more fully set out in the definition of 'real property' in clause 1. intellectual property means any patents, trademarks etc. as more fully defined in clause 1.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ploutos Agency Llc
    Transazioni
    • 04 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 mar 2017
    Consegnato il 04 apr 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ploutos Agency Llc
    Transazioni
    • 04 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 gen 2016
    Consegnato il 22 gen 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 22 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 gen 2016
    Consegnato il 25 gen 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 25 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 gen 2016
    Consegnato il 25 gen 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 25 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 gen 2016
    Consegnato il 22 gen 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 22 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 set 2015
    Consegnato il 28 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Fixed security over all freehold and leasehold property in england and wales ('real property'); fixed security over any present or future intellectual property. For more details, please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 28 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 lug 2015
    Consegnato il 20 lug 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 lug 2014
    Consegnato il 16 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 16 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 20 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in melrose resources romania bv.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 20 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in melrose petroleum company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 20 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in melrose resources sarl.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 20 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in odyssey international petroleum LTD. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 13 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 mag 2013
    Consegnato il 15 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Security Trustee (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge agreement
    Creato il 24 ott 2012
    Consegnato il 05 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first priority pledge on the pledged assets being all rights titles interests and benefit in to and under the shares and all distributions relating to the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 07 feb 2012
    Consegnato il 09 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in us dollars designated ltsb re melrose resources PLC and numbered 11701789 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus acknowledgement of security interests
    Creato il 23 giu 2008
    Consegnato il 08 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from grantors or any of them, to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company for the benefit of the secured creditors confirm all liens and security interests granted under the existing security documents shall continue. A lien on and security interest in all of the companys property and assets described in each existing security document see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee (Bos)
    Transazioni
    • 08 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Amendment agreement
    Creato il 23 giu 2008
    Consegnato il 08 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    As continuing security for the due and full payment, discharge and performance of all the secured obligations, the pledgor, as full and sole owner of shares, pledges it's right, title and interest to the shares to. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent of the Secured Creditors
    Transazioni
    • 08 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge amendment
    Creato il 23 giu 2008
    Consegnato il 08 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from obligors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    100,000 common shares in the capital of the issuer shall be and become part of the collateral referred to in the pledge agreement, pursuant to which the collateral is pledged in favour of the security agent see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 08 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge agreement
    Creato il 23 giu 2008
    Consegnato il 08 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from obligors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    13,633 common shares in the issuer shall be and become part of the collateral referred to in the pledge agreement, pursuant to which the collateral is pledged in favour of the security agent see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 08 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share charge
    Creato il 23 giu 2008
    Consegnato il 07 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, all dividends or interest paid, all securities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 07 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0