BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED

BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03211797
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED?

    • Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Old Steine
    Brighton
    BN1 1EJ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 giu 2012

    Stato del capitale al 28 giu 2012

    • Capitale: GBP 266,622
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2006

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2005

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2004

    5 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 2003

    16 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NATHAN, Daniel Alexander Julian
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    Segretario
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    British75162990004
    BRATHWAITE, James Everett
    Church Farm House
    Rectory Lane
    BN16 4JU Angmering
    West Sussex
    Amministratore
    Church Farm House
    Rectory Lane
    BN16 4JU Angmering
    West Sussex
    EnglandBritish203668080001
    NATHAN, Daniel Alexander Julian
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    Amministratore
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    EnglandBritish75162990004
    STARK, Steven
    2 Salem Cottage The Street
    TN22 5NL Framfield
    East Sussex
    Amministratore
    2 Salem Cottage The Street
    TN22 5NL Framfield
    East Sussex
    EnglandBritish73968890003
    FRANCIS, Sharon Lesley
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    Segretario
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    British72419260001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    PERERA, Brandon Jayalath
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    British54457210001
    PERERA, Eugene Indrajit
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    Segretario
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    British56569640002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    AUBREY FLETCHER, Henry Egerton, Sir
    Town Hill Farm Dorton Road
    Chilton
    HP18 9NA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Town Hill Farm Dorton Road
    Chilton
    HP18 9NA Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish22980850001
    AXTON, Ian James
    29 Andrews Way
    SP2 8QR Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    29 Andrews Way
    SP2 8QR Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish52042080001
    CARNEGY, Christopher Roy
    29 Hulse Road
    SP1 3LU Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    29 Hulse Road
    SP1 3LU Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish5024600002
    DRUMMOND, Gordon
    7 Blunden Drive
    Cuckfield
    RH17 5HU Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    7 Blunden Drive
    Cuckfield
    RH17 5HU Haywards Heath
    West Sussex
    British34139600003
    FANSHAWE, Simon Hew Dalrymple
    10 Keslake House
    14 Chichester Terrace
    BN2 1FG Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    10 Keslake House
    14 Chichester Terrace
    BN2 1FG Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish50512000001
    FLANAGAN, Mark Simon
    14 Denehurst Gardens
    W3 9QY London
    Amministratore
    14 Denehurst Gardens
    W3 9QY London
    British69776160004
    FRANCIS, Sharon Lesley
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    Amministratore
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    British72419260001
    HALLETT, Lawrence Albert, Dr
    565 Earlham Road
    NR4 7TF Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    565 Earlham Road
    NR4 7TF Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish12078930003
    HARBER, David
    Flat 3, 22 Salisbury Road
    BN3 3AE Hove
    Amministratore
    Flat 3, 22 Salisbury Road
    BN3 3AE Hove
    British96014070001
    JOSEPHS, John Irving
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish3830990001
    KNIGHT, William Roger
    10 Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    10 Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish26945620001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    NATHAN, Daniel Alexander Julian
    6b Steine Gardens
    BN2 1WB Brighton
    Amministratore
    6b Steine Gardens
    BN2 1WB Brighton
    British75162990002
    NICE, Timothy Christopher
    Rebels Roost
    Finches Lane, Twyford
    SO21 1QF Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Rebels Roost
    Finches Lane, Twyford
    SO21 1QF Winchester
    Hampshire
    British66693480002
    PERERA, Brandon Jayalath
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    British54457210001
    PERERA, Eugene Indrajit
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    British56569640002
    RADFORD KIRBY, Simon Gerard
    66 Greenways
    Ovingdean
    BN2 7BL Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    66 Greenways
    Ovingdean
    BN2 7BL Brighton
    East Sussex
    British50035890001
    SHAW, Barry
    18 Ayzgarth Rise
    YO16 7HX Bridlington
    East Yorkshire
    Amministratore
    18 Ayzgarth Rise
    YO16 7HX Bridlington
    East Yorkshire
    British96413730001
    SMITH, William Alexander
    19 Arundel Street
    BN2 5TG Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    19 Arundel Street
    BN2 5TG Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish48903440001
    SORBY-FIRTH, Erika
    45 Stanley Road
    SG2 0EE Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Stanley Road
    SG2 0EE Stevenage
    Hertfordshire
    British59119380001
    STARK, Steven
    F15/50 Rochester Gardens
    BN3 3HT Hove
    East Sussex
    Amministratore
    F15/50 Rochester Gardens
    BN3 3HT Hove
    East Sussex
    British73968890001
    WEBB, Martin Jonathan
    15 Montpelier Villas
    BN1 3DG Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    15 Montpelier Villas
    BN1 3DG Brighton
    East Sussex
    British55939610002
    WINGATE, Guy David Alexander
    Basement Flat 7 Pilgrims Lane
    NW3 1SJ London
    Amministratore
    Basement Flat 7 Pilgrims Lane
    NW3 1SJ London
    British17365640001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 ott 2002
    Consegnato il 22 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Mark
    Transazioni
    • 22 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Mark
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 nov 2001
    Consegnato il 24 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1998
    Consegnato il 14 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Wayleave agreement
    Creato il 26 feb 1998
    Consegnato il 04 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    £5,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Deposit account of £5,000.
    Persone aventi diritto
    • Sussex Heights (Brighton) Limited
    Transazioni
    • 04 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0