J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED

J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03213011
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ in data 14 set 2015

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2015

    Stato del capitale al 05 ago 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagineAD02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 11 gen 2015 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Caroline Jane Sellers come segretario in data 30 set 2014

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 ago 2014

    • Capitale: GBP 100.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 31 lug 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2013

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NUTTALL, John Branson
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Amministratore
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Amministratore
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritish137558680001
    CAPLAN, Linda
    43 The Fairway
    LS17 7PE Leeds
    Yorkshire
    Segretario
    43 The Fairway
    LS17 7PE Leeds
    Yorkshire
    British48267370001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Segretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MARKS, Philip Louis Howard
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    British55339760001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150200880001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Segretario nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375350001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    CAPLAN, Jeffrey Howard
    43 The Fairway
    LS17 7PE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    43 The Fairway
    LS17 7PE Leeds
    West Yorkshire
    British17303130001
    CAPLAN, Linda
    43 The Fairway
    LS17 7PE Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    43 The Fairway
    LS17 7PE Leeds
    Yorkshire
    British48267370001
    DAVIS, Estelle Denise
    41 The Mount
    LS17 7RH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 The Mount
    LS17 7RH Leeds
    West Yorkshire
    British55339780001
    EVANS, Nia Haf
    6 Thorneyholme Drive
    WA16 8BT Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    6 Thorneyholme Drive
    WA16 8BT Knutsford
    Cheshire
    British85570730001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Amministratore
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish87486470001
    MARKS, Philip Louis Howard
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    British55339760001
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    British44967060001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375270001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    J.H. CAPLAN PHARMACY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 05 nov 1997
    Consegnato il 12 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the f/h and l/h property of the company,including the property k/a 275 burley road,leeds t/no.wyk 422372 and the proceeds of sale thereof together with all buildings,structures and fixtures from time to time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 09 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 05 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate and k/a 275 burley road leeds west yorkshire t/no:-wyk 422372.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0