BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED

BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03213650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILL HILL SOCCER CENTRE LIMITED 05 set 199605 set 1996
    POWERLEAGUE HENDON LTD07 ago 199607 ago 1996
    CROWNCREST LEISURE LIMITED18 giu 199618 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2010

    Stato del capitale al 08 lug 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sean Tracey il 18 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sheena Marion Beckwith il 18 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Sheena Marion Beckwith il 18 giu 2010

    1 pagineCH03

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 28 giu 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 giu 2007

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 01 lug 2006

    8 pagineAA

    legacy

    10 pagine363s

    Bilancio redatto al 02 lug 2005

    14 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Certificato di riduzione del capitale emesso

    1 pagineCERT15

    legacy

    5 pagineOC138

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Chi sono gli amministratori di BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BECKWITH, Sheena Marion
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Segretario
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    British77381700002
    BECKWITH, Sheena Marion
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Amministratore
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    ScotlandBritish77381700002
    TRACEY, Sean Paul
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Amministratore
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    ScotlandBritish105080540001
    HALL, Jeremy Clive
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    Segretario
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    British35444860001
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Segretario nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish67066450003
    HALL, Jeremy Clive
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish35444860001
    MOORE, Adrian Richard
    1 Chaucer Close
    SL4 3ER Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    1 Chaucer Close
    SL4 3ER Windsor
    Berkshire
    UkBritish96121170001
    ORMEROD, Warren David
    34 Old Oak Close
    WS9 8SE Aldridge
    West Midlands
    Amministratore
    34 Old Oak Close
    WS9 8SE Aldridge
    West Midlands
    British49052640001
    SELLERS, Philip Edward
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10598350001
    TAYLOR, Alan Lewis
    6 Heathside Close
    Moor Park
    HA6 2EQ Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    6 Heathside Close
    Moor Park
    HA6 2EQ Northwood
    Middlesex
    British4947700001
    FIRST DIRECTORS LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Amministratore delegato nominato
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000770001

    BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the investors (as defined) under the investment agreement of even date pursuant to the deed of guarantee of even date
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 dic 1999
    Consegnato il 11 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 ago 1999
    Consegnato il 12 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 02 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Excluding the legally charged property and including stocks and shares acquired pursuant to scrip dividends and other than royalties and other sums payable in respect of all intellectual property rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 02 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H land at pursley road hendon london borough of barnet. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0