OHI BEAUMONT PARK LTD

OHI BEAUMONT PARK LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOHI BEAUMONT PARK LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03213741
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OHI BEAUMONT PARK LTD?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Tower 42 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BEAUMONT PARK LIMITED22 mag 200222 mag 2002
    PINELAKE CARE LIMITED18 giu 199618 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2016

    21 pagineAA

    legacy

    35 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 set 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 27/09/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Dettagli del segretario cambiati per Daniel J Booth il 01 mar 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Stephenson il 01 mar 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Ritz il 01 mar 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Booth il 01 mar 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Citypoint Level 33 1 Ropemaker Street London EC2Y 9UE England a Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ in data 28 apr 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA

    legacy

    32 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 18 giu 2016

    23 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 18 giu 2015

    23 pagineRP04AR01

    Chi sono gli amministratori di OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOOTH, Daniel J
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Segretario
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    197726300001
    BOOTH, Daniel James
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Amministratore
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican265749890001
    RITZ, Michael Daniel
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Amministratore
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican231342520001
    STEPHENSON, Robert
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Amministratore
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican196594350001
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    Segretario
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    British82185990001
    BOGGON, Deirdre Irene
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    British51553190001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    Segretario
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    British7897560001
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Segretario
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    British96916290001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BATES, David John
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish96384800003
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    Amministratore
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    EnglandBritish82185990001
    CHRISTIAN, Deborah Helen
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish187897170001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    Amministratore
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    EnglandBritish7897560002
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish147828420021
    ROGERS, Pamela Anne
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    Amministratore
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    British63140670001
    STOTT, Yvette Ann
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    British56606030001
    WARD, Gordon Robert
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    Amministratore
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    British48287480003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    06 apr 2016
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione03995046
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    OHI BEAUMONT PARK LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk SK275266; the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk NK338434; fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk SK145383 (for further details of properties charged please refer to form 395) and/or its proceeds of sale. Floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 08 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk t/no SK275266 the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk t/no NK338434 fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk t/no SK145383 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 08 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 ago 2005
    Consegnato il 11 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2002
    Consegnato il 12 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 2002
    Consegnato il 12 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage over all that freehold property known as west of shortmead street biggleswade and freehold property on the west side of shortmead street biggleswade. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 2000
    Consegnato il 30 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land and buildings on the west side of shortmead st biggleswade known as beaumont park shortmead st biggleswade t/no BD123120 BD127708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 30 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge over chattels
    Creato il 26 set 2000
    Consegnato il 30 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    With full title guarantee by way of first fixed charge: 1)the fixed assets together with any and all assets subsequently acquired by the company by way of replacement thereof 2)items of real or personal property tangible or intangible . fixed assets: 37 beds 37 wardrobes 37 chairs. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 30 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ago 1996
    Consegnato il 31 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a land and premises at shotmead street, biggleswade bedford t/n's BD123120 and BD127708 assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ago 1996
    Consegnato il 31 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0