ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03213768 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Brew House Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington Cheshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WALKERN DEVELOPMENTS LIMITED | 19 giu 1996 | 19 giu 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di beni vacanti | 1 pagine | BONA | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 06 feb 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Stewart Murphy come amministratore in data 08 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Spencer Adrian Kenyon come amministratore in data 08 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Bryan Carroll come amministratore in data 08 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Simon Darke come amministratore in data 08 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carolyn Jones come amministratore in data 22 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Bryan Carroll il 27 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Paul Bryan Carroll come amministratore in data 16 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Simon Darke il 20 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL, Orla Marie | Amministratore | WA4 6HL Greenalls Avenue The Brew House Warrington United Kingdom | England | British | Company Secretary | 199861060001 | ||||||||
ASSURA CS LIMITED | Amministratore | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Cheshire United Kingdom |
| 149895250002 | ||||||||||
ARCHER, Peter Monahan | Segretario | Blackthorne Lane Ballinger HP16 9LF Great Missenden Mulberry Cottage Buckinghamshire United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 65693680001 | |||||||||
JOHNSON, Lesley Karen | Segretario | 64 Magnolia Way Pilgrims Hatch CM15 9PP Brentwood Essex | British | 39447270001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ARCHER, Peter Monahan | Amministratore | Blackthorne Lane Ballinger HP16 9LN Great Missenden Mulberry Cottage Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 65693680002 | ||||||||
ATKINS, Rodney Blake | Amministratore | 43 Wilbury Road SG6 4JW Letchworth Hertfordshire | British | Company Director | 39476150004 | |||||||||
CARROLL, Paul Bryan | Amministratore | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Cheshire | England | British | Accountant | 85123780001 | ||||||||
DARKE, Andrew Simon | Amministratore | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Cheshire United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 65166580004 | ||||||||
HARRISON, Michael | Amministratore | Lee Place Hazel Road KT14 6JJ West Byfleet Surrey | British | Solicitor | 41908660001 | |||||||||
JONES, Carolyn | Amministratore | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House England England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 159034310014 | ||||||||
KENYON, Spencer Adrian | Amministratore | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House England England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 200693360001 | ||||||||
MURPHY, Jonathan Stewart | Amministratore | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 121699680002 | ||||||||
RUTTER, Francesca Louise | Amministratore | Red Lion Hill The Lee HP16 9NF Great Missenden Red Lion House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 105129780003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assura Financing Limited | 19 apr 2016 | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Assura Investments Limited | 06 apr 2016 | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House England England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of assignment | Creato il 26 apr 2006 Consegnato il 12 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title benefits and interests of the company to all moneys from time to time owing or incurred to the company under the lease. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed | Creato il 26 apr 2006 Consegnato il 12 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The grove surgery farthing grove netherfield milton keynes including all buildings erections and fixtures and fixed plant and machinery all moneys from time to time deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment and charge | Creato il 27 giu 2005 Consegnato il 06 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title benefit and interest in the development agreement dated 8TH june 2005. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment | Creato il 29 lug 2002 Consegnato il 30 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of claremont medical centre, 1-3 arlington road, surbiton, surrey. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of legal charge | Creato il 19 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, cgnu PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever | |
Brevi particolari Maisonette and crystal house 1-3 arlington road surbiton surrey t/nos. SGL248188 and TGL148609 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 mag 1998 Consegnato il 08 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land forming part of finches farm walkern part t/n HD357507 and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and equipment, all right title and interest in any proceeds of insurance, any present and future goodwill and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 mar 1997 Consegnato il 21 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property k/a part of finches farm house walkern t/n HD273697. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 mar 1997 Consegnato il 20 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £201,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All that f/h land forming part of finches farm house walkern and having a frontage to high street walkern hertfordshire and in part registered under t/no..HD273697. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0