ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED

ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03213768
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Brew House
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WALKERN DEVELOPMENTS LIMITED19 giu 199619 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 feb 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Jonathan Stewart Murphy come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Spencer Adrian Kenyon come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Bryan Carroll come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Simon Darke come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Carolyn Jones come amministratore in data 22 ott 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Bryan Carroll il 27 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 19 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 giu 2016

    Stato del capitale al 28 giu 2016

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Nomina di Mr Paul Bryan Carroll come amministratore in data 16 dic 2015

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Simon Darke il 20 apr 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALL, Orla Marie
    WA4 6HL Greenalls Avenue
    The Brew House
    Warrington
    United Kingdom
    Amministratore
    WA4 6HL Greenalls Avenue
    The Brew House
    Warrington
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary199861060001
    ASSURA CS LIMITED
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7184790
    149895250002
    ARCHER, Peter Monahan
    Blackthorne Lane
    Ballinger
    HP16 9LF Great Missenden
    Mulberry Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Blackthorne Lane
    Ballinger
    HP16 9LF Great Missenden
    Mulberry Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    BritishChartered Surveyor65693680001
    JOHNSON, Lesley Karen
    64 Magnolia Way
    Pilgrims Hatch
    CM15 9PP Brentwood
    Essex
    Segretario
    64 Magnolia Way
    Pilgrims Hatch
    CM15 9PP Brentwood
    Essex
    British39447270001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARCHER, Peter Monahan
    Blackthorne Lane
    Ballinger
    HP16 9LN Great Missenden
    Mulberry Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Blackthorne Lane
    Ballinger
    HP16 9LN Great Missenden
    Mulberry Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director65693680002
    ATKINS, Rodney Blake
    43 Wilbury Road
    SG6 4JW Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    43 Wilbury Road
    SG6 4JW Letchworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director39476150004
    CARROLL, Paul Bryan
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    Amministratore
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant85123780001
    DARKE, Andrew Simon
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor65166580004
    HARRISON, Michael
    Lee Place Hazel Road
    KT14 6JJ West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Lee Place Hazel Road
    KT14 6JJ West Byfleet
    Surrey
    BritishSolicitor41908660001
    JONES, Carolyn
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    Amministratore
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant159034310014
    KENYON, Spencer Adrian
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    Amministratore
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor200693360001
    MURPHY, Jonathan Stewart
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director121699680002
    RUTTER, Francesca Louise
    Red Lion Hill
    The Lee
    HP16 9NF Great Missenden
    Red Lion House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Hill
    The Lee
    HP16 9NF Great Missenden
    Red Lion House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor105129780003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    19 apr 2016
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione10023274
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    06 apr 2016
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4677200
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ABBEY HEALTHCARE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment
    Creato il 26 apr 2006
    Consegnato il 12 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title benefits and interests of the company to all moneys from time to time owing or incurred to the company under the lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 26 apr 2006
    Consegnato il 12 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The grove surgery farthing grove netherfield milton keynes including all buildings erections and fixtures and fixed plant and machinery all moneys from time to time deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 27 giu 2005
    Consegnato il 06 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest in the development agreement dated 8TH june 2005.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 29 lug 2002
    Consegnato il 30 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of claremont medical centre, 1-3 arlington road, surbiton, surrey.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 30 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of legal charge
    Creato il 19 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, cgnu PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Maisonette and crystal house 1-3 arlington road surbiton surrey t/nos. SGL248188 and TGL148609 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1998
    Consegnato il 08 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land forming part of finches farm walkern part t/n HD357507 and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and equipment, all right title and interest in any proceeds of insurance, any present and future goodwill and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 08 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a part of finches farm house walkern t/n HD273697. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & the Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 1997
    Consegnato il 20 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £201,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that f/h land forming part of finches farm house walkern and having a frontage to high street walkern hertfordshire and in part registered under t/no..HD273697.
    Persone aventi diritto
    • Michael John Smith and Carolyn Jean Smith and the Said Michael John Smithand Joyce Winifred Smith
    Transazioni
    • 20 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0