ELECTRONIQUE GROUP LIMITED

ELECTRONIQUE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELECTRONIQUE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03214376
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O ROBNOR RESINS LIMITED
    31 Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RAVENGOLD LIMITED19 giu 199619 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Robnor Resins Limited Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE a C/O C/O Robnor Resins Limited 31 Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE in data 21 ott 2015

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2014

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Crawford Wilson Gillan come amministratore in data 16 feb 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Crawford Wilson Gillan come segretario in data 16 feb 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2015

    Stato del capitale al 19 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2014

    Stato del capitale al 17 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Frederick Hawley come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Crawford Wilson Gillan come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Crawford Wilson Gillan come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr John Rae Henderson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Frederick Hawley come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gilles Coulombeau come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    pagineANNOTATION

    Bilancio annuale redatto al 19 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Gilles Maire Jean Francois Coulombeau il 01 mar 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    11 pagineAA

    Stato del capitale al 28 lug 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENDERSON, John Rae
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    Amministratore
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    ScotlandBritish43301650001
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    Segretario
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    182622810001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    British13540840002
    HARPER CORPORATION LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Segretario nominato
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013980001
    COULOMBEAU, Gilles Maire Jean Francois
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomFrench15117870004
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    Amministratore
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    United KingdomBritish182618510001
    HARDIE, Reginald George
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    British422650001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish13540840002
    LING, Philip Henry
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish2326420001
    WALTON, Michael Edward D'Arcy
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    Amministratore
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    EnglandBritish34866270001
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Amministratore delegato nominato
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013970001

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 21 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    65,002 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of electronique limited and all stocks securities and other property charged under the terms of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a units 2A and 2B hulme hall lane manchester t/n GM413956. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a unit b harwood road littlehampton t/n WSX54330. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a unit a harwood road littlehampton t/n WSX50703. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a land on the west side of byrom street liverpool t/n MS125497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 2 harwood road littlehampton t/n WSX79974. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 42-48 fentenoy street liverpool t/n MS124039. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 feb 1999
    Consegnato il 23 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For property details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of keyman policy
    Creato il 10 mar 1997
    Consegnato il 19 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The life assurance policy dated 16 february 1996 issuedby crowe life on tthe life of colin douglas murray for the amount of £100,000 contract no. 733/Rml 16762 certificate number sed 1289 and all sums assured thereby and bonuses and benefits arising thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brevi particolari
    Crowe life assurance company policy no.sed 1221 dated 13.9.96 over the life of christopher james wilkins, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brevi particolari
    Crowe life assurance company policy no.sed 1217 dated 13.9.96 over the life of david smith, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brevi particolari
    Crowe life assurance company policy no.sed 1219 dated 13.9.96 over the life of giles marie coulombeau, sum assured:£500,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brevi particolari
    Crowe life assurance company policy no.sed 1218 dated 13.9.96 over the life of neil ancell, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman policy
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brevi particolari
    Crowe life assurance company policy no.sed 1220 dated 13.9.96 over the life of fredrick william hawley, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and charge
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 02 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lands and premises situate in the townland of killyhevlin parish of enniskillen barony of tirkennedy and county fermanagh .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 02 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0