BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03214421
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRUNTWOOD SECOND PROPERTIES LIMITED12 ago 199612 ago 1996
    BRUNTWOOD SECOND ESTATES LIMITED19 lug 199619 lug 1996
    SLATERSHELFCO 318 LIMITED20 giu 199620 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT a C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB in data 07 giu 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 apr 2016

    Stato del capitale al 12 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 apr 2015

    Stato del capitale al 09 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2014

    Stato del capitale al 08 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin James Crotty il 28 giu 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Kevin James Crotty come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Allan come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* in data 05 gen 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Robert Yates come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Marland come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Malin come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Iain Grant come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Crowther come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Segretario
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    British96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritish117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Segretario
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Segretario nominato
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish80043450001
    CROWTHER, Peter Andrew
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish102710080002
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Amministratore
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritish2582690002
    GUEST, David Robert James
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish102710440001
    HEWITT, Michael
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish108552010001
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish48153170001
    MARLAND, John Roderick
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish102712120001
    MORRIS, Antony Howard
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    Amministratore
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    British48178610001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ROBERTS, Christopher Andrew
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139641910001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish30535590006

    BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    B2000 borrower security agreement
    Creato il 06 feb 2007
    Consegnato il 20 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transazioni
    • 20 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 2004
    Consegnato il 01 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a overseas house, quay street t/no LA355462 together with all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon, all plant, machinery, implements, utensils, building materials, carpets, furniture andequipment now or in the future placed on or used in or about the mortgaged prope. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transazioni
    • 01 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 03 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the freehold property known as overseas house quay street t/n LA355462 by way of fixed charge all plant machinery implements building materials all of the companys rights and benefits under any agreements and the benefit of each and all of the personal covenants by the lesses underlesses or licensees under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 2000
    Consegnato il 24 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining marsland house,marsland rd,sale,gt.manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 1999
    Consegnato il 30 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a lancastrian office buildings talbot road stretford greater manchester t/n-LA234523.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 27 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and and buildings k/a bank house faulkner street manchester t/no.LA360892. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 27 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the l/h land and buildings k/a bank chambers adjoining bank house faulkner street manchester being the whole of the land under t/nos.GM789357 and GM789673. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 15 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a marsland house marsland road sale t/nos.GM53071 and GM323015 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a quay house 28 quay street manchester t/n GM66438 the goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 nov 1996
    Consegnato il 19 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0