OVERSON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOVERSON LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03214899
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di OVERSON LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova OVERSON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Recovery Hjs
    12 -14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OVERSON LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2007
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 apr 2008
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2006

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per OVERSON LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 giu 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 lug 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OVERSON LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per OVERSON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Charles Henry Pfister come segretario in data 07 mag 2015

    2 pagineTM02

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    5 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    6 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    10 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2006

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2005

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2004

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return29 giu 2004

    legacy

    363(287)
    annual-return29 giu 2004

    legacy

    363(288)

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2003

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2002

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    Chi sono gli amministratori di OVERSON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    Segretario
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    PFISTER, Charles Henry
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    British67081640001
    BURGON, Mark Edward
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritish100433200001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OVERSON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 30 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land forming part of the garden of the property known as outerfield,tilford road,hindhead; part t/no sy 108357. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 24 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold land formerly part of the property outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Persone aventi diritto
    • Mirafora Themistocli
    Transazioni
    • 24 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 24 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Persone aventi diritto
    • Carolyn Mary Popham
    Transazioni
    • 24 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 24 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Persone aventi diritto
    • Montagu Graeme Macdonald
    Transazioni
    • 24 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 gen 2002
    Consegnato il 05 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a land adjoining courts mount road haslemere surrey.
    Persone aventi diritto
    • C.H. Pfister & R.J. Hager as Trustees of D M Hager Discretionary Settlement
    Transazioni
    • 05 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 25 gen 2002
    Consegnato il 05 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land adjoining courts mount barn courts mount road haslemere surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 2001
    Consegnato il 20 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 15 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Persone aventi diritto
    • R J Hager(As Trustees of the Mrs D M Hager 1997 Settlement)
    • C H Pfister
    Transazioni
    • 15 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Robert Michael Macdonald
    • Montagu Graeme Macdonald
    • Carolyn Mary Popham
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Donald Slough
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 01 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H part of the old bus depot midhurst west sussex. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of whole
    Creato il 19 nov 1999
    Consegnato il 19 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000 due from the company to the chargee in accordance with the terms of the supplemental agreement of even date
    Brevi particolari
    F/Hold land lying to the north east of petworth rd,haslemere and garages; t/no sy 677075.
    Persone aventi diritto
    • Carolyn Mary Popham
    Transazioni
    • 19 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of whole
    Creato il 03 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due or to become due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    Land to the north of petworth road haslemere and garages surrey.
    Persone aventi diritto
    • Carolyn Mary Popham and Robert Michael Macdonald
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 03 giu 1998
    Consegnato il 05 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to the rear of 24 petworth road haslemere surrey t/n SY677075. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of whole
    Creato il 19 nov 1997
    Consegnato il 21 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    Land and buildings adjacent to greencroft scotland drive haslemere surreyt/no.SY248372.
    Persone aventi diritto
    • Carolyn Mary Popham
    • Robert Michael Macdonald
    Transazioni
    • 21 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed floating charge
    Creato il 13 ott 1997
    Consegnato il 14 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 18TH august 1997
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the wheatsheaf grayswood roaf witley haslemere surrey t/n SY382663 and by way of floating charge the undertaking of the company and all it's property assets and rights present and future.
    Persone aventi diritto
    • Plt Limited
    Transazioni
    • 14 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 mag 1997
    Consegnato il 22 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjacent to greencroft scotland drive haslemere surrey t/n-SY248372 by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 07 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 8TH july 1996 and this charge
    Brevi particolari
    First fixed legal mortgage f/h property k/a the cottages verdley place furnhurst chichester west sussex first fixed charge all the company's right title and interest in any account from time to time opened and maintained by the company in accordance with the provisions of this charge and all monies (including interest thereon) standing from time to time to the credit of such account. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Plt Limited
    Transazioni
    • 07 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of whole
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 01 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £140,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    C1-C8 and GC1-GC5 verdley place fernhurst t/no wsx 195964.
    Persone aventi diritto
    • Mrs Dulcie Marguerite Hager
    Transazioni
    • 01 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OVERSON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 feb 2007Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Shane Biddlecombe
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Praticante
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Gordon John Johnston
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Praticante
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0