CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03215195
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INSUREMONEY LIMITED21 giu 199621 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    24 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    26 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Suite a 6 Honduras Street London EC1Y 0th United Kingdom a The Inspire Hornbeam Square West Harrogate HG2 8PA

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di London Registrars Ltd come segretario in data 30 giu 2017

    1 pagineTM02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata The Inspire Hornbeam Square West Harrogate North Yorkshire HG2 8PA

    1 pagineAD04

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 gen 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 29 gen 2016

    28 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 29 gen 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Chi sono gli amministratori di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURRELL, James Alexander
    One Eagle Place
    St James's
    SW1Y 6AF London
    2nd Floor
    England
    Amministratore
    One Eagle Place
    St James's
    SW1Y 6AF London
    2nd Floor
    England
    United KingdomBritishCompany Director192486560001
    TROY, Anthony Gerrard
    One Eagle Place
    St James's
    SW1Y 6AF London
    2nd Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    One Eagle Place
    St James's
    SW1Y 6AF London
    2nd Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishCompany Director104500230001
    BYRNE, Bernard
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    154495120001
    CURRIE, Timothy
    17 Dearnford Close
    Bromborough
    L62 6EW Wirral
    Merseyside
    Segretario
    17 Dearnford Close
    Bromborough
    L62 6EW Wirral
    Merseyside
    British31227210001
    NORTON, Geoffrey Richard
    17 Roehampton Drive
    Blundellsands
    L23 7XD Liverpool
    Segretario
    17 Roehampton Drive
    Blundellsands
    L23 7XD Liverpool
    British42030440004
    LONDON REGISTRARS LTD
    6 Honduras Street
    EC1Y 0TH London
    Suite A
    England
    Segretario
    6 Honduras Street
    EC1Y 0TH London
    Suite A
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03215195
    204801060001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRABNER, Michael Graham
    Grendon
    28 Abbey Road
    L48 7EP West Kirby
    Wirral Mersyside
    Amministratore
    Grendon
    28 Abbey Road
    L48 7EP West Kirby
    Wirral Mersyside
    United KingdomBritishSolicitor18716010002
    BYRNE, Bernard
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrishSurveyor/ Cd34374340004
    ISAAC, Roger
    Ravenswood Mayes Green
    Ockley
    RH5 5PN Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Ravenswood Mayes Green
    Ockley
    RH5 5PN Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Manager50664640001
    MORRIS, Graham Charles
    Mulberry Tree House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mulberry Tree House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishProperty Finance Consultant52054730001
    NORTON, Geoffrey Richard
    17 Roehampton Drive
    Blundellsands
    L23 7XD Liverpool
    Amministratore
    17 Roehampton Drive
    Blundellsands
    L23 7XD Liverpool
    EnglandBritishChartered Surveyor42030440004
    WALLIS, William George
    2 Stoneleigh Gardens
    Grappenhall
    WA4 3LE Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    2 Stoneleigh Gardens
    Grappenhall
    WA4 3LE Warrington
    Cheshire
    BritishChartered Surveyor14725020001
    WILKINSON, John Michael
    8 Arley End
    High Legh
    WA16 6NA Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    8 Arley End
    High Legh
    WA16 6NA Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant2260190001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Castlewood Securities Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 apr 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione03040863
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of legal charge made between (1) castlewood securities limited and castlewood property management limited and martin's building (holdings) limited ("initial chargor") and (2) norwich union mortgage finance limited ("trustee")
    Creato il 20 apr 2001
    Consegnato il 09 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to any lender or for or in respect of which any group member may be liable to any lender whether present or future actual or contingent on any account whatsoever (all terms as defined)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the property all that freehold land known as martins buildings 4 water street liverpool (post code L2 3SX) title number MS298686 and all that leasehold land known as martins buildings 4 water street liverpool (post code L2 3SX) title number MS388074 including all buildings erections and fixtures and fittings 9EXCLUDING tenants fixtures and fittings) and fixed plant equipment and machinery for the time being thereon and all improvements and additions and all easements rights licences appurtenant thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same ut otherwise free from encumbrance and includes all other property subject to the legal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment made between (1) castlewood securities limited and castlewood property management limited ("companies") and (2) norwich union mortgage finance limited ("trustee")
    Creato il 20 apr 2001
    Consegnato il 09 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to any lender or for or in respect of which any group member may be liable to any lender whether present or future actual or contingent on any account whatsoever (all terms as defined)
    Brevi particolari
    By way of security to the trustee all the assigned rights being all the rights titles benefits and interests whether present or future of the companies to the rents (as defined in the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 feb 1999
    Consegnato il 15 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to all or any of the secured parties (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Martins building 4 water street liverpool t/n MS388074. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Capital Inc.(As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 nov 1996
    Consegnato il 11 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and castlewood securities limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Property Mezzanine Partners LP
    Transazioni
    • 11 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1996
    Consegnato il 05 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or castlewood securities limited ("the borrower") to the chargee pursuant to the terms of the agreement dated 30 january 1996 and any other loan facility pursuant thereto (as defined therein)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the l/h property k/a martins buildings 4 water street liverpool and a floating charge the undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transazioni
    • 05 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0