CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
Nome della società | CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03215195 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
INSUREMONEY LIMITED | 21 giu 1996 | 21 giu 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 26 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Suite a 6 Honduras Street London EC1Y 0th United Kingdom a The Inspire Hornbeam Square West Harrogate HG2 8PA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di London Registrars Ltd come segretario in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata The Inspire Hornbeam Square West Harrogate North Yorkshire HG2 8PA | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 gen 2017 al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 gen 2016 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 29 gen 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURRELL, James Alexander | Amministratore | One Eagle Place St James's SW1Y 6AF London 2nd Floor England | United Kingdom | British | Company Director | 192486560001 | ||||||||
TROY, Anthony Gerrard | Amministratore | One Eagle Place St James's SW1Y 6AF London 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | Company Director | 104500230001 | ||||||||
BYRNE, Bernard | Segretario | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | 154495120001 | |||||||||||
CURRIE, Timothy | Segretario | 17 Dearnford Close Bromborough L62 6EW Wirral Merseyside | British | 31227210001 | ||||||||||
NORTON, Geoffrey Richard | Segretario | 17 Roehampton Drive Blundellsands L23 7XD Liverpool | British | 42030440004 | ||||||||||
LONDON REGISTRARS LTD | Segretario | 6 Honduras Street EC1Y 0TH London Suite A England |
| 204801060001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BRABNER, Michael Graham | Amministratore | Grendon 28 Abbey Road L48 7EP West Kirby Wirral Mersyside | United Kingdom | British | Solicitor | 18716010002 | ||||||||
BYRNE, Bernard | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | Irish | Surveyor/ Cd | 34374340004 | ||||||||
ISAAC, Roger | Amministratore | Ravenswood Mayes Green Ockley RH5 5PN Dorking Surrey | United Kingdom | British | Investment Manager | 50664640001 | ||||||||
MORRIS, Graham Charles | Amministratore | Mulberry Tree House Devonshire Avenue HP6 5JF Amersham Buckinghamshire | England | British | Property Finance Consultant | 52054730001 | ||||||||
NORTON, Geoffrey Richard | Amministratore | 17 Roehampton Drive Blundellsands L23 7XD Liverpool | England | British | Chartered Surveyor | 42030440004 | ||||||||
WALLIS, William George | Amministratore | 2 Stoneleigh Gardens Grappenhall WA4 3LE Warrington Cheshire | British | Chartered Surveyor | 14725020001 | |||||||||
WILKINSON, John Michael | Amministratore | 8 Arley End High Legh WA16 6NA Knutsford Cheshire | England | British | Chartered Accountant | 2260190001 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castlewood Securities Limited | 06 apr 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CASTLEWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of legal charge made between (1) castlewood securities limited and castlewood property management limited and martin's building (holdings) limited ("initial chargor") and (2) norwich union mortgage finance limited ("trustee") | Creato il 20 apr 2001 Consegnato il 09 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys obligations and liabilities which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to any lender or for or in respect of which any group member may be liable to any lender whether present or future actual or contingent on any account whatsoever (all terms as defined) | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the property all that freehold land known as martins buildings 4 water street liverpool (post code L2 3SX) title number MS298686 and all that leasehold land known as martins buildings 4 water street liverpool (post code L2 3SX) title number MS388074 including all buildings erections and fixtures and fittings 9EXCLUDING tenants fixtures and fittings) and fixed plant equipment and machinery for the time being thereon and all improvements and additions and all easements rights licences appurtenant thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same ut otherwise free from encumbrance and includes all other property subject to the legal charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment made between (1) castlewood securities limited and castlewood property management limited ("companies") and (2) norwich union mortgage finance limited ("trustee") | Creato il 20 apr 2001 Consegnato il 09 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys obligations and liabilities which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to any lender or for or in respect of which any group member may be liable to any lender whether present or future actual or contingent on any account whatsoever (all terms as defined) | |
Brevi particolari By way of security to the trustee all the assigned rights being all the rights titles benefits and interests whether present or future of the companies to the rents (as defined in the form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 11 feb 1999 Consegnato il 15 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to all or any of the secured parties (as defined) under each finance document (as defined) | |
Brevi particolari Martins building 4 water street liverpool t/n MS388074. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 nov 1996 Consegnato il 11 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and castlewood securities limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 nov 1996 Consegnato il 05 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or castlewood securities limited ("the borrower") to the chargee pursuant to the terms of the agreement dated 30 january 1996 and any other loan facility pursuant thereto (as defined therein) | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the l/h property k/a martins buildings 4 water street liverpool and a floating charge the undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0