ACTUATE UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | ACTUATE UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03216097 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ACTUATE UK LIMITED?
- Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
Dove si trova ACTUATE UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 420 Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading Berkshire England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ACTUATE UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ACTUATE U.K. LIMITED | 24 ago 1999 | 24 ago 1999 |
ACTUATE SOFTWARE UK LIMITED | 16 lug 1996 | 16 lug 1996 |
SPEED 5699 LIMITED | 25 giu 1996 | 25 giu 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ACTUATE UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ACTUATE UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 04 feb 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Oliver Jon Gallienne il 01 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Waida il 01 mar 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2018 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione di Open Text Corporation, Which is Listed on the Nasdaq and Toronto Stock Exchange come persona con controllo significativo il 01 lug 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Open Text Corporation, Which is Listed on the Nasdaq and Toronto Stock Exchange come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Open Text Uk Limited come persona con controllo significativo il 01 lug 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Actuate International Corporation come persona con controllo significativo il 01 lug 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Nomina di Madhu Ranganathan come amministratore in data 31 mag 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Marshall Doolittle come amministratore in data 31 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2017 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gordon Allan Davies il 18 ago 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Actuate International Corporation come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Waida il 01 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ACTUATE UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIES, Gordon Allan | Amministratore | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Berkshire England | Canada | Canadian | Chief Legal Officer & Corporate Development | 149569500009 | ||||||||
GALLIENNE, Oliver Jon | Amministratore | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Berkshire England | England | English | Svp, Professional Services | 207070550001 | ||||||||
RANGANATHAN, Madhu | Amministratore | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Berkshire England | United States | American | Evp & Chief Financial Officer | 247241460001 | ||||||||
WAIDA, Christian | Amministratore | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Berkshire England | United Kingdom | German | Svp & General Counsel, Commercial Operations | 102915690003 | ||||||||
AUJLA, Amarjit | Segretario | 1 Limmer Close RG41 4DF Wokingham Berkshire | British | Accountant | 53912690001 | |||||||||
FERAILLE, Irina | Segretario | Le Zible 813 La Roche 1634 Switzerland | British | 105024580001 | ||||||||||
LONGIA, Amar Raj | Segretario | 23 Cadwell Drive SL6 3YS Maidenhead Berkshire | British | Accountant | 86492630001 | |||||||||
MCNAMARA, Ted | Segretario | En Chenallaz 2 1740neyruz 1740 Switzerland | American | 86979840001 | ||||||||||
PON, James Edwin | Segretario | Grand Places 14 1700 Fribourg Switzerland | American | Public Accountant | 79731530001 | |||||||||
WHITTINGHAM, John Andrew | Segretario | 151 Purley Oaks Road CR2 0NZ South Croydon Surrey | British | 68141040001 | ||||||||||
SALANS HERTZFELD & HEILBRONN | Segretario | 103 Mount Street W1Y 5HE London | 48709650001 | |||||||||||
SALANS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4AJ London Millennium Bridge House England |
| 70173300001 | ||||||||||
VP SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 4 Coleman Street EC2R 5AR London 6th Floor England |
| 176810270001 | ||||||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
AUJLA, Amarjit | Amministratore | 1 Limmer Close RG41 4DF Wokingham Berkshire | England | British | Accountant | 53912690001 | ||||||||
BERMAN, John Michael | Amministratore | 14 Caroline Terrace SW1W 8JS London | United Kingdom | British | Company Director | 13050490002 | ||||||||
CHANCERELLE, Patrick Denis | Amministratore | 34 Rue Du Prof Guyon 784030 Louveciennes France | French | Operation Manager | 50242850001 | |||||||||
DOOLITTLE, John Marshall | Amministratore | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Berkshire England | Canada | Canadian | Chief Financial Officer | 151416140001 | ||||||||
FERRIER, Andrew John | Amministratore | Angofcstrasse 28 81825 FOREIGN Munich Germany | British | Company Director | 62120670001 | |||||||||
GACHOT, Olivier | Amministratore | 25 Barcelona Circle Redwood Shores Ca 94065 Usa | French | Vp Sales | 65565450001 | |||||||||
GAUDREAU, Daniel | Amministratore | 19327 Vendura Ct Saratoga Ca 95070 Usa | Usa | American | Cfo | 65564860003 | ||||||||
HAMILTON, Alan Kenneth | Amministratore | 212 Finchampstead Road RG40 3HB Wokingham Berkshire | British | General Manager/Md | 141683550001 | |||||||||
HARRISON, Simon David | Amministratore | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Berkshire England | England | British | Svp, Enterprise Sales | 158647800002 | ||||||||
MAXWELL, John | Amministratore | 275 East Blithedale Avenue Mill Valley California 94941 Usa | American | Director | 116726830001 | |||||||||
MCNAMARA, Ted | Amministratore | En Chenallaz 2 1740neyruz 1740 Switzerland | Switzerland | American | Director | 86979840001 | ||||||||
PON, James Edwin | Amministratore | 185 Ripley Street FOREIGN San Francisco Ca, 94110 | Usa | American | Director | 79731530002 | ||||||||
SHEPPARD, Richard John | Amministratore | 4 Redlands Place RG41 4ED Wokingham Berkshire | British | Vp Emea | 67955960001 | |||||||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ACTUATE UK LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Text Uk Limited | 01 lug 2018 | Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Open Text Corporation, Which Is Listed On The Nasdaq And Toronto Stock Exchange | 06 apr 2016 | Frank Tompa Drive Waterloo 275 Ontario, N2l 0a1 Canada | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Actuate International Corporation | 06 apr 2016 | Orange Street Wilmington 1209 Delaware United States | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ACTUATE UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 20 nov 2006 Consegnato il 30 nov 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £131,476.63 and the amount from time to time standing to the credit of the deposit account and all interest credited to the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 nov 1999 Consegnato il 04 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 set 1998 Consegnato il 10 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Ad all book/other debts and benefit of all contracts policies of insurance thereunder. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0