PHIP CH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHIP CH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03217536
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHIP CH LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PHIP CH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHIP CH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED11 mag 200411 mag 2004
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED12 mag 199912 mag 1999
    PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED01 mag 199801 mag 1998
    ANVIL LONDON LIMITED27 giu 199627 giu 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHIP CH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PHIP CH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr David Christopher Austin come amministratore in data 01 apr 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy David Walker Arnott come amministratore in data 01 apr 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Howell come amministratore in data 01 apr 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip John Holland come amministratore in data 01 apr 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip John Holland il 08 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 lug 2015

    Stato del capitale al 10 lug 2015

    • Capitale: GBP 1,333
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2014

    Stato del capitale al 30 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,333
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy David Walker Arnott il 01 mag 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy David Walker Arnott il 22 lug 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Nexus Management Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* in data 07 mag 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Margaret Vaughan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di J O Hambro Capital Management Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 25 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 lug 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PHIP CH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Segretario
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4187765
    57253330002
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish35560380005
    DEAMER, Kenneth
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    Segretario
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    British8521670002
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish47179960002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    STEVENS, Philip Martin
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    British102528350001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Segretario
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2176004
    117915530003
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish14707370002
    BORER, Derek
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    British60451400001
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Amministratore
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish53684400001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish163838050001
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomIrish47179960002
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Amministratore
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    Amministratore
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    British23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    Amministratore
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Amministratore
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish123167120001
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish61889360004
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PHIP CH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    01 giu 2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione3033634
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    PHIP CH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 apr 2012
    Consegnato il 04 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 mar 2008
    Consegnato il 28 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2008
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 2006
    Consegnato il 15 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 gen 2006
    Consegnato il 17 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 gen 2006
    Consegnato il 11 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 nov 2004
    Consegnato il 02 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0