AMERIN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMERIN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03220089
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMERIN LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova AMERIN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMERIN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUSABA EATHAI LTD.09 lug 199909 lug 1999
    BUSABA UK LIMITED08 dic 199808 dic 1998
    CHELSEA CORPORATION LIMITED03 lug 199603 lug 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMERIN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 mag 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per AMERIN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    10 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da 42-48 Great Portland Street (C/O Busaba) London W1W 7NB a 6th Floor, 2 London Wall Place London EC2Y 5AU in data 07 apr 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 24 mar 2022

    LRESEX

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 27 mag 2020 al 14 set 2020

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Marc Whitehead come amministratore in data 09 dic 2020

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 032200890016, creata il 30 nov 2020

    58 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 032200890017, creata il 30 nov 2020

    35 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 032200890015, creata il 30 gen 2020

    29 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 mag 2018

    2 pagineAA

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Marc Whitehead come amministratore in data 02 nov 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brigid Hughes come segretario in data 19 ott 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Brigid Hughes come amministratore in data 19 ott 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Terence Harrison come amministratore in data 19 ott 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di AMERIN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRISON, Terence Ernest
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    6th Floor, 2
    Amministratore
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    6th Floor, 2
    EnglandBritish251636120001
    ERENTOK YAU, Nuriye Jale
    Flat 1
    39 Charlotte Street
    W1T 1RU London
    Segretario
    Flat 1
    39 Charlotte Street
    W1T 1RU London
    British114113920002
    HUGHES, Brigid
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    Segretario
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    165996090001
    MCCAFFREY, Anna
    42 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    Segretario
    42 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    British55303210002
    SEIFERT, Michael
    49 Elgin Crescent
    W11 2JU London
    Segretario
    49 Elgin Crescent
    W11 2JU London
    British74504290001
    WINTER, Sarah Joy
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    Segretario
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    British99111550001
    YAU, Alan Tak Wai
    Flat 27
    29 Seward Street
    EC1V 3DA London
    Segretario
    Flat 27
    29 Seward Street
    EC1V 3DA London
    British49834400006
    YAU, Linda Yen Tin
    Flat 5 Hydra Building
    10 Hardwick Street
    EC1R 4RB London
    Segretario
    Flat 5 Hydra Building
    10 Hardwick Street
    EC1R 4RB London
    British85358630003
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Segretario nominato
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    ALI, Amin
    93 Dudley Court
    Endell Street
    WC2H 9RJ Covent Garden
    London
    Amministratore
    93 Dudley Court
    Endell Street
    WC2H 9RJ Covent Garden
    London
    British50332430001
    DATTANI, Sunil
    19 Parkthorne Drive
    North Harrow
    HA2 7BU Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    19 Parkthorne Drive
    North Harrow
    HA2 7BU Harrow
    Middlesex
    British14402700001
    ERENTOK YAU, Nuriye Jale
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    Amministratore
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    United KingdomBritish114113920002
    GEE, Stephen Trevor
    Church Farm Barns
    SN16 9TE Oaksey
    Wiltshire
    Amministratore
    Church Farm Barns
    SN16 9TE Oaksey
    Wiltshire
    United KingdomBritish30701840007
    HUGHES, Brigid
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    Amministratore
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    EnglandAustralian178244040001
    KELLY, Timothy
    42 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    Amministratore
    42 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    British55303260001
    LOMBARDO, Marc
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    Amministratore
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    EnglandBritish206572810001
    SEIFERT, Michael
    Flat 1, 17 Holland Park
    W11 3TD London
    Amministratore
    Flat 1, 17 Holland Park
    W11 3TD London
    EnglandBritish74504290002
    WHITEHEAD, Marc
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    Amministratore
    Great Portland Street (C/O Busaba)
    W1W 7NB London
    42-48
    EnglandBritish252179480001
    WINTER, Sarah Joy
    16 Anglers Reach
    Grove Road
    KT6 4EU Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    16 Anglers Reach
    Grove Road
    KT6 4EU Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish99111550002
    YAU, Alan Tak Wai
    Flat 1, 39 Charlotte Street
    W1T 1KR London
    Amministratore
    Flat 1, 39 Charlotte Street
    W1T 1KR London
    United KingdomBritish49834400006
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Amministratore delegato nominato
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per AMERIN LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    26 giu 2019La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    AMERIN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2020
    Consegnato il 02 dic 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Tnui Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2020
    Consegnato il 02 dic 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 gen 2020
    Consegnato il 03 feb 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 03 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 giu 2016
    Consegnato il 23 giu 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 23 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 2010
    Consegnato il 19 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H ground floor 8-13 fird street london t/no NGL837581.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 nov 2010
    Consegnato il 17 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 set 2005
    Consegnato il 14 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £150,000 plus £26,250 vat totalling £176,250. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal London Mutual Insurance Society Limited
    Transazioni
    • 14 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 15 apr 2005
    Consegnato il 26 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 106-110 wardour street, london t/no NGL765538. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 apr 2005
    Consegnato il 22 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 apr 2005
    Consegnato il 22 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 8-13 bird street, london t/no NGL837581. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 mag 2004
    Consegnato il 20 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    £130,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Ground floor, 8-13 bird street, london.
    Persone aventi diritto
    • Noble House Pub Company Limited
    Transazioni
    • 20 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 26 ago 1999
    Consegnato il 01 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 106, 108 and 110 wardour street london-NGL765538. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 ago 1999
    Consegnato il 01 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counterpart performance guarantee
    Creato il 21 mag 1999
    Consegnato il 02 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 20TH march 1998 between (1) the queens most excellent majesty (2) the crown estate commissioners and (3) chelsea corporation limited (now known as busaba UK limited) and all documents supplemental thereto relating to property known as 106/110 wardour street london W1
    Brevi particolari
    To secure the carrying out of works under the terms of the lease inclusive of all right title and interest in the "bond" (£25,000 provided by the company under the deed). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commissioners
    Transazioni
    • 02 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 mag 1999
    Consegnato il 02 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £64,061.46 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease dated 20TH march 1998 between (1) the queens most excellent majesty (2) the crown estate commissioners and (3) the chelsea corporation limited (now known as busaba UK limited) amd all deeds supplemental thereto in relation to property known as 106/110 wardour street london W1
    Brevi particolari
    All obligations of the company contained in the lease of 20TH march 1998 including all right title and interest in the initial deposit of £64,061.46 and all related rights thereto and thereof under the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commissioners
    Transazioni
    • 02 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 mar 1998
    Consegnato il 27 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease
    Brevi particolari
    The initial deposit of £62,000.00 relating to ground floor and basement at 106 108 and 110 wardour street london W1.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commissioners on Behalf of Her Majestyacting in Exercise of the Powers of the Crown Estate Act 1961
    Transazioni
    • 27 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    AMERIN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2022Inizio della liquidazione
    30 ago 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Colin John Sanders
    6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Praticante
    6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Georgina Marie Eason
    6th Floor, 2 London Wall Place
    Barbican
    EC2Y 5AU London
    Praticante
    6th Floor, 2 London Wall Place
    Barbican
    EC2Y 5AU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0