GAMEPLAY (GB) LIMITED

GAMEPLAY (GB) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGAMEPLAY (GB) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03221027
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    • (5245) /

    Dove si trova GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAMEPLAY (EUROPE) LIMITED18 mag 200018 mag 2000
    INTERACTIVE COMMERCIAL ENTERPRISES LTD.05 lug 199605 lug 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 gen 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 set 2015

    12 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 set 2015

    9 pagine2.24B

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.38B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 mar 2015

    18 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 set 2014

    17 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Benjamin White come amministratore in data 08 ago 2014

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 mar 2014

    18 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2014

    18 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 ago 2013

    19 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2013

    17 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Unity House Telford Road Basingstoke Hampshire RG21 6YJ* in data 29 ott 2012

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 set 2012

    19 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Ian Shepherd come amministratore

    2 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Vivienne Hemming come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ian Shepherd come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul John Blunden come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Crowne come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GAMEPLAY (GB) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLUNDEN, Paul John
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish167658770001
    BECHMAN, Theodor Robert
    14 Conway Road
    Wimbledon
    SW20 8PA London
    Segretario
    14 Conway Road
    Wimbledon
    SW20 8PA London
    British100392340001
    BURKE, Lisa Jane
    11 Garsdale Fold
    Collingham
    LS22 5LT West Yorkshire
    Segretario
    11 Garsdale Fold
    Collingham
    LS22 5LT West Yorkshire
    British82942660001
    COUPER, Amanda Julie
    129 Tottenham Road
    N1 4EA London
    Segretario
    129 Tottenham Road
    N1 4EA London
    British70621340001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Segretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Segretario
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British125932650001
    WILK, Stasia
    43 Wilmer Road
    BD9 4RX Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    43 Wilmer Road
    BD9 4RX Bradford
    West Yorkshire
    British48434460002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BECHMAN, Theodor Robert
    14 Conway Road
    Wimbledon
    SW20 8PA London
    Amministratore
    14 Conway Road
    Wimbledon
    SW20 8PA London
    United KingdomBritish100392340001
    BERNSTEIN, Mark Jonathan
    The Old Rectory
    Nock Verges
    LE5 4DA Stoney Stanton
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Nock Verges
    LE5 4DA Stoney Stanton
    Leicestershire
    United KingdomBritish151556960002
    BLACKBURN, Steven
    Flat 204,Zinc House
    19-25 Cowcross Street
    EC1M 6DH London
    Amministratore
    Flat 204,Zinc House
    19-25 Cowcross Street
    EC1M 6DH London
    British67264840002
    BURKE, Lisa Jane
    Wood Grove
    Linton Lane
    LS22 4HL Linton
    Amministratore
    Wood Grove
    Linton Lane
    LS22 4HL Linton
    British82942660002
    CLARK, Stephen Nicholas
    16 Jacks Lane
    Harefield
    UB9 6HE Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    16 Jacks Lane
    Harefield
    UB9 6HE Uxbridge
    Middlesex
    UkBritish27147310001
    COLES, Timothy Richard
    19 Stanley Avenue
    HP5 2JG Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    19 Stanley Avenue
    HP5 2JG Chesham
    Buckinghamshire
    British78510020002
    CROFT, Alexander Bernard James
    Porthleven House
    19 Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Porthleven House
    19 Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritish87618090002
    CROWNE, Peter Charles
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    United KingdomBritish106991580002
    DOYLE, Andrew James
    24 Curzon Road
    Muswell Hill
    N10 2RA London
    Amministratore
    24 Curzon Road
    Muswell Hill
    N10 2RA London
    British73807230002
    DUFFY, Colin
    77 Dean Court Road
    BN2 7DL Rottingdean
    East Sussex
    Amministratore
    77 Dean Court Road
    BN2 7DL Rottingdean
    East Sussex
    United KingdomBritish107994450001
    JONES, Michael Graham
    1 Sycamore Court
    Oakwood
    LS8 2NY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Sycamore Court
    Oakwood
    LS8 2NY Leeds
    West Yorkshire
    British93246490001
    MEE, Andrew
    Wood Grove
    Linton Lane, Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wood Grove
    Linton Lane, Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish122316010001
    MORGAN, Lisa Jayne
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    British38420460004
    ROBERTS, Charles Anthony
    5 Fernhurst Crescent
    WF14 9TE Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Fernhurst Crescent
    WF14 9TE Mirfield
    West Yorkshire
    British49699890001
    SHEPHERD, Ian
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish153448920001
    STRACHAN, Mark Douglas
    Wales House
    Wales, Queen Camel
    BA22 7PA Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Wales House
    Wales, Queen Camel
    BA22 7PA Yeovil
    Somerset
    British66472620001
    THOMAS, David Fraser
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    Amministratore
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    EnglandBritish27763020003
    WARREN, Richard
    27 Green Road
    RG6 7BS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    27 Green Road
    RG6 7BS Reading
    Berkshire
    EnglandBritish67264660001
    WHITE, Benjamin
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritish133790090002
    WILK, Dylan
    42 Woodville Court
    Park Villas
    LS8 1JA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    42 Woodville Court
    Park Villas
    LS8 1JA Leeds
    West Yorkshire
    British48434450002

    GAMEPLAY (GB) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 mar 2011
    Consegnato il 15 mar 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2009
    Consegnato il 04 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present and future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 04 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 11 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (In Such Capacity,the 'Security Trustee')
    Transazioni
    • 11 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 07 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 23 gen 2003
    Consegnato il 29 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 9127739 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 ago 2000
    Consegnato il 15 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £80,000 plus vat due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £80,000 plus vat.
    Persone aventi diritto
    • Sterling Capitol Securities PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GAMEPLAY (GB) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 mar 2012Inizio dell'amministrazione
    25 set 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart David Maddison
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Praticante
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0