GREATFLEET PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREATFLEET PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03223519
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREATFLEET PLC?

    • (7450) /

    Dove si trova GREATFLEET PLC?

    Indirizzo della sede legale
    One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREATFLEET PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LONGBRIDGE INTERNATIONAL PLC18 nov 199618 nov 1996
    STREAMFIELD PLC11 lug 199611 lug 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREATFLEET PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per GREATFLEET PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 apr 2011

    7 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 gen 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 lug 2010

    5 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 lug 2009

    28 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    28 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 gen 2009

    27 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    17 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    51 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine122

    legacy

    2 pagine123

    Risoluzioni

    Resolutions
    48 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Consolodation 07/04/2008
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di GREATFLEET PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAILEY, Wayne Anthony
    44 Ryelaw Road
    GU52 6HY Church Crookham
    Hampshire
    Segretario
    44 Ryelaw Road
    GU52 6HY Church Crookham
    Hampshire
    BritishFinancial Controller125079050001
    BAKER, John William, Sir
    Troika House
    The Bothy
    GU22 8UD Pyrford
    Surrey
    Amministratore
    Troika House
    The Bothy
    GU22 8UD Pyrford
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director65699350002
    GERSTEIN, Colin
    2 Avenue Road
    St Johns Wood
    NW8 7PU London
    2
    Amministratore
    2 Avenue Road
    St Johns Wood
    NW8 7PU London
    2
    EnglandBritishDirector132055020001
    LASSMAN, Keith
    7 The Oaks
    WD19 4LR Oxhey
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 The Oaks
    WD19 4LR Oxhey
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor52423420002
    GRANT, Nigel John
    22 Upper Park Road
    KT2 5LD Kingston
    Surrey
    Segretario
    22 Upper Park Road
    KT2 5LD Kingston
    Surrey
    BritishFinance Director92021190001
    LASSMAN, Malcolm Arnold
    99 Woodlands
    NW11 9QT London
    Segretario
    99 Woodlands
    NW11 9QT London
    British2910610001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BLAKE, Stuart John
    2 Cedar Lane
    Burghill
    HR4 7QQ Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    2 Cedar Lane
    Burghill
    HR4 7QQ Hereford
    Herefordshire
    BritainBritishCompany Director95561040001
    BROWN, Peter Michael
    12 Hyde Park Place
    W2 2LH London
    Amministratore
    12 Hyde Park Place
    W2 2LH London
    EnglandBritishCompany Director1788540001
    COX, Antony John
    6 68 Great Cumberland Place
    W1H 7TD London
    Amministratore
    6 68 Great Cumberland Place
    W1H 7TD London
    BritishDirector125912820002
    FOSTER, Martin
    61 Biggleswade Road
    Upper Caldecote
    SG18 9BH Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Biggleswade Road
    Upper Caldecote
    SG18 9BH Biggleswade
    Bedfordshire
    United KingdomBritishAccountant70902540001
    FRENCH, Christopher Paul Martin
    Evergreens Surbiton Golf Course
    Woodstock Lane
    KT9 1UF Chessington
    Surrey
    Amministratore
    Evergreens Surbiton Golf Course
    Woodstock Lane
    KT9 1UF Chessington
    Surrey
    BritishCompany Director29819470001
    GRANT, Nigel John
    22 Upper Park Road
    KT2 5LD Kingston
    Surrey
    Amministratore
    22 Upper Park Road
    KT2 5LD Kingston
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director92021190001
    HILL, Jonathan Clive
    California House
    1 California Lane
    IP8 3QJ Hintlesham
    Suffolk
    Amministratore
    California House
    1 California Lane
    IP8 3QJ Hintlesham
    Suffolk
    BritishBanker16671290005
    JAMES, Trevor Malcolm
    46 Vogans Mill Mill Street
    SE1 2BZ London
    Amministratore
    46 Vogans Mill Mill Street
    SE1 2BZ London
    BritishCompany Director57792700001
    LASSMAN, Keith
    7 The Oaks
    WD19 4LR Oxhey
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 The Oaks
    WD19 4LR Oxhey
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor52423420002
    NEWBY, Peter John
    3 Wellside Gardens
    East Sheen
    SW14 7AD London
    Amministratore
    3 Wellside Gardens
    East Sheen
    SW14 7AD London
    BritishFinance Director77788850001
    PAGE, Bruce Godwin
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    Amministratore
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director21298720001
    PAGE, Bruce Godwin
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    Amministratore
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    United KingdomBritishDirector21298720001
    RYAN, Hugh Francis
    2 Lancaster Cottages
    Lancaster Park
    TW10 6AE Richmond
    Surrey
    Amministratore
    2 Lancaster Cottages
    Lancaster Park
    TW10 6AE Richmond
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22895280001
    RYVES, David Ranston
    55 Hartley Down
    CR8 4EF Purley
    Surrey
    Amministratore
    55 Hartley Down
    CR8 4EF Purley
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director18272250001
    VARELA, Frank Javier
    Elenge Plat
    Grouse Road
    RH13 6HT Colgate
    West Sussex
    Amministratore
    Elenge Plat
    Grouse Road
    RH13 6HT Colgate
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director50655930002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    GREATFLEET PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 set 2007
    Consegnato il 15 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Capital Venture Finance Limited
    Transazioni
    • 15 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 dic 2006
    Consegnato il 04 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sme Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 01 lug 2005
    Consegnato il 07 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Capital Venture Finance Limited
    Transazioni
    • 07 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 giu 2004
    Consegnato il 08 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums to the credit of the interest bearing deposit account,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dartvale Corporation Nv
    Transazioni
    • 08 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture deed
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 19 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 gen 1998
    Consegnato il 26 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date herewith
    Brevi particolari
    £226,725.
    Persone aventi diritto
    • Gracechurch Street Investments Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GREATFLEET PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 lug 2009Fine dell'amministrazione
    29 lug 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Charles Healy
    Leonard Curtis
    One Great Cumberland Place
    W1H 7LW Marble Arch
    London
    Praticante
    Leonard Curtis
    One Great Cumberland Place
    W1H 7LW Marble Arch
    London
    Paul Robert Boyle
    Harrisons
    3 St Giles Court
    RG1 2QL Southampton Street
    Reading
    Praticante
    Harrisons
    3 St Giles Court
    RG1 2QL Southampton Street
    Reading
    2
    DataTipo
    09 lug 2009Inizio della liquidazione
    11 ago 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Charles Healy
    Leonard Curtis
    One Great Cumberland Place
    W1H 7LW Marble Arch
    London
    Praticante
    Leonard Curtis
    One Great Cumberland Place
    W1H 7LW Marble Arch
    London
    Paul Robert Boyle
    4 St Giles Court
    Southampton Street
    RG1 2QL Reading
    Praticante
    4 St Giles Court
    Southampton Street
    RG1 2QL Reading

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0