SANDALBEECH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SANDALBEECH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03229904 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SANDALBEECH LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova SANDALBEECH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Beachamp Court 10 Victors Way EN5 5TZ Barnet Hertfordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di SANDALBEECH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per SANDALBEECH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mar 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF a 1 Beachamp Court 10 Victors Way Barnet Hertfordshire EN5 5TZ in data 17 lug 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Philip Levy come amministratore in data 18 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sheila Braude come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sheila Braude come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Nicholas Maurice Slater come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Monica Slater come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SANDALBEECH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLATER, Nicholas Maurice | Amministratore | 239 Regents Park Road N3 3LF London Gable House United Kingdom | England | British | 53423100002 | |||||
| SLATER, Norman Henry | Amministratore | 13 Dennis Lane HA7 4JR Stanmore Middlesex | England | British | 25275530002 | |||||
| BRAUDE, Sheila | Segretario | Fuller Close WD23 4JD Bushey Flat 2 Herne Mansions | British | 128788760001 | ||||||
| BROOKER, Wendy | Segretario | 44 Merlin Grove BR3 3HU Beckenham Kent | British | 22526050001 | ||||||
| HURWORTH, Maureen | Segretario | Warren End 1a Riddlesdown Avenue Purley CR8 1JH Croydon Surrey | British | 48945190001 | ||||||
| HURWORTH, Maureen | Segretario | Warren End 1a Riddlesdown Avenue Purley CR8 1JH Croydon Surrey | British | 48945190001 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| BRAUDE, Sheila | Amministratore | Fuller Close WD23 4JD Bushey Flat 2 Herne Mansions | England | British | 128788760001 | |||||
| HURWORTH, Maureen | Amministratore | Warren End 1a Riddlesdown Avenue Purley CR8 1JH Croydon Surrey | British | 48945190001 | ||||||
| LEVY, Daniel Philip | Amministratore | 67 Fountain House Park Street W1K 6HG London | British | 85549940001 | ||||||
| SLATER, Monica | Amministratore | Dennis Lane HA7 4JR Stanmore 13 Middlesex | England | British | 25275520002 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SANDALBEECH LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxland Ltd | 06 apr 2016 | 10 Victors Way EN5 5TZ Barnet 1 Beauchamp Court Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SANDALBEECH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage of parent guarantee | Creato il 01 mag 2007 Consegnato il 18 mag 2007 | In corso | Importo garantito All obligations of barratt developments PLC to sandalbeech limited | |
Brevi particolari A guarantee dated 19 may 2006 and granted by barratt developments limited to the company in respect of obligations of kingsoak homes limited under an agreement date 19 may 2006. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of agreement for lease | Creato il 01 mag 2007 Consegnato il 09 mag 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari An agreement dated 19TH may 2006 between the company and kingsoak properties limited and interest in all contracts present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Sub-charge | Creato il 01 mag 2007 Consegnato il 09 mag 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A mortgage of the property k/a 10/12 upton road and land on the north west side of exchange road watford hertfordshire and all principal interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 giu 2005 Consegnato il 10 giu 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a land being on the west side of loates lane watford and otherwise k/a 10 beechen grove loates lane, watford t/no HD233833. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 apr 2004 Consegnato il 06 apr 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land being land on the south west side of stratford road, shirley, f/h land at the rear of the property known as 820 stratford road, shirley, f/h land known as 818 stratford road, shirley (refer to form 395 for further details). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 02 mag 2003 Consegnato il 09 mag 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Chade works 172-180 (even) high street south dunstable bedfordshire t/n BD37755 and BD37258. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 dic 2002 Consegnato il 30 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0