SANDALBEECH LIMITED

SANDALBEECH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSANDALBEECH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03229904
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SANDALBEECH LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SANDALBEECH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Beachamp Court
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SANDALBEECH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per SANDALBEECH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mar 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2015

    Stato del capitale al 27 lug 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF a 1 Beachamp Court 10 Victors Way Barnet Hertfordshire EN5 5TZ in data 17 lug 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 set 2014

    Stato del capitale al 17 set 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Daniel Philip Levy come amministratore in data 18 giu 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sheila Braude come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sheila Braude come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 set 2013

    Stato del capitale al 12 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Nicholas Maurice Slater come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Monica Slater come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SANDALBEECH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SLATER, Nicholas Maurice
    239 Regents Park Road
    N3 3LF London
    Gable House
    United Kingdom
    Amministratore
    239 Regents Park Road
    N3 3LF London
    Gable House
    United Kingdom
    EnglandBritish53423100002
    SLATER, Norman Henry
    13 Dennis Lane
    HA7 4JR Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    13 Dennis Lane
    HA7 4JR Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish25275530002
    BRAUDE, Sheila
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    Segretario
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    British128788760001
    BROOKER, Wendy
    44 Merlin Grove
    BR3 3HU Beckenham
    Kent
    Segretario
    44 Merlin Grove
    BR3 3HU Beckenham
    Kent
    British22526050001
    HURWORTH, Maureen
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    Segretario
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    British48945190001
    HURWORTH, Maureen
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    Segretario
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    British48945190001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Segretario nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BRAUDE, Sheila
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    Amministratore
    Fuller Close
    WD23 4JD Bushey
    Flat 2 Herne Mansions
    EnglandBritish128788760001
    HURWORTH, Maureen
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Warren End 1a Riddlesdown Avenue
    Purley
    CR8 1JH Croydon
    Surrey
    British48945190001
    LEVY, Daniel Philip
    67 Fountain House
    Park Street
    W1K 6HG London
    Amministratore
    67 Fountain House
    Park Street
    W1K 6HG London
    British85549940001
    SLATER, Monica
    Dennis Lane
    HA7 4JR Stanmore
    13
    Middlesex
    Amministratore
    Dennis Lane
    HA7 4JR Stanmore
    13
    Middlesex
    EnglandBritish25275520002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Amministratore delegato nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SANDALBEECH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Boxland Ltd
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    10 Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    1 Beauchamp Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneNot Specified/Other
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione00321082
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SANDALBEECH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of parent guarantee
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 18 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All obligations of barratt developments PLC to sandalbeech limited
    Brevi particolari
    A guarantee dated 19 may 2006 and granted by barratt developments limited to the company in respect of obligations of kingsoak homes limited under an agreement date 19 may 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of agreement for lease
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement dated 19TH may 2006 between the company and kingsoak properties limited and interest in all contracts present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Sub-charge
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A mortgage of the property k/a 10/12 upton road and land on the north west side of exchange road watford hertfordshire and all principal interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 giu 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land being on the west side of loates lane watford and otherwise k/a 10 beechen grove loates lane, watford t/no HD233833. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2004
    Consegnato il 06 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land being land on the south west side of stratford road, shirley, f/h land at the rear of the property known as 820 stratford road, shirley, f/h land known as 818 stratford road, shirley (refer to form 395 for further details). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 09 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chade works 172-180 (even) high street south dunstable bedfordshire t/n BD37755 and BD37258.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 30 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0