CELLULAR OPERATIONS LIMITED

CELLULAR OPERATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCELLULAR OPERATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03231393
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GUARDSURE PLC30 lug 199630 lug 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Ms Diane Mcintyre come amministratore in data 01 gen 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peregrine Douglas Gonzague Riviere come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    legacy

    207 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    Cessazione della carica di Diego Galli come amministratore in data 01 mag 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peregrine Douglas Gonzague Riviere come amministratore in data 01 mag 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 14 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mar 2016

    Stato del capitale al 15 mar 2016

    • Capitale: GBP 150,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    BUNTER, Nigel Stephen Gilmore
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director69955750001
    DAVIS, Clive Clayton
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    Segretario
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    British92013820001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    BUNTER, Nigel Stephen Gilmore
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director69955750001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    DARBY, Gavin John
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector99277850001
    DAVIS, Clive Clayton
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    Amministratore
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    BritishChartered Accountant92013820001
    DEV, Vivek
    Connought House
    Ledborough Gate Ledborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Amministratore
    Connought House
    Ledborough Gate Ledborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    BritishChartered Accountant79178710001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    GALLI, Diego
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianCompany Director171566420001
    HARRIS, Brian Athol
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)AustralianHead Of Enterprise Finance135937300001
    KNIGHT, Nigel Phillip
    The Old Barn, Formby Hall
    Southport Old Road, Formby
    L37 0AB Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    The Old Barn, Formby Hall
    Southport Old Road, Formby
    L37 0AB Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director70898900001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Richard Ashleigh
    29 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5HH London
    Amministratore
    29 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5HH London
    United KingdomBritishCompany Director11980050001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LOGAN, Hugh
    7 Tresham Drive
    Grappenhall
    WA4 3DU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    7 Tresham Drive
    Grappenhall
    WA4 3DU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishM.D.119332280001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    MOFFAT, Simon Alexander
    Greyfriars
    17 Pony Chase
    KT11 2PF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Greyfriars
    17 Pony Chase
    KT11 2PF Cobham
    Surrey
    BritishFinance Director41139540002
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector139360020001
    QADRI, Sohail
    122 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5HP London
    Amministratore
    122 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5HP London
    BritishManager52341900001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector87149560001
    RIVIERE, Peregrine Douglas Gonzague
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector207135750001
    SCHA*FER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support150941520001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianDirector103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    BritishFinancial Director95223480001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3942192
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2227940
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CELLULAR OPERATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 22 gen 2003
    Consegnato il 08 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a sites 1 and 2 and the land at the north side of peatmoor way hillmead t/n WT177342 and WT190205.
    Persone aventi diritto
    • Nigel Bunter
    Transazioni
    • 08 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 22 gen 2003
    Consegnato il 08 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a sites 1 and 2 and the land at the north side of peatmoor way hillmead t/n WT177342 and WT190205.
    Persone aventi diritto
    • Richard Lee
    Transazioni
    • 08 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge (the supplemental charge) which is supplemental to a deed of charge made on 11 may 2000 between the company and vodafone limited
    Creato il 16 feb 2001
    Consegnato il 05 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 05 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 15 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of a service provider agreement dated 28 june 2000
    Brevi particolari
    First fixed charge all claims choses in action intellectual property goodwill under the service provider agreement and all book debts; floating charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transazioni
    • 15 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 11 mag 2000
    Consegnato il 27 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreement of even date
    Brevi particolari
    First fixed charge choses in action intellectual property goodwill and alll book debts; floating charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 mar 1999
    Consegnato il 01 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Computer equipment/telephone system as per goods listed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second legal charge
    Creato il 01 mar 1999
    Consegnato il 17 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as set out in clause 21 and schedule 4 of a development agreement dated 10.12.1998 (as defined),payments from the building contractor relating to the office development of the premises charged,fees of ec harris and curona designs limited in connection with the said development and any additional amounts payable under the agreement dated 10.12.1998
    Brevi particolari
    F/Hold land at hillmead way,swindon,wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Highbridge Properties PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of security assignment and agreement
    Creato il 23 feb 1999
    Consegnato il 12 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreements (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and all benefits to accrue to it in respect of the building contract, the parent company guarantee, the appointments and the performance bond under the first deed of assignment and the development agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 nov 1998
    Consegnato il 08 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1998
    Consegnato il 11 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a site off meadway hillmead enterprise park swindon wiltshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit deed
    Creato il 03 lug 1998
    Consegnato il 09 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two leases both of even date
    Brevi particolari
    A deposit of £138,000 held by the chargee with lloyds bank PLC covent garden branch.
    Persone aventi diritto
    • Sun Alliance & London Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to airtime charges
    Brevi particolari
    Second fixed and floating charge over custoner recievables.
    Persone aventi diritto
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 27TH march 1997
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0