CELLULAR OPERATIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CELLULAR OPERATIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03231393 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
- Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
Dove si trova CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GUARDSURE PLC | 30 lug 1996 | 30 lug 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ms Diane Mcintyre come amministratore in data 01 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peregrine Douglas Gonzague Riviere come amministratore in data 01 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 207 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Diego Galli come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peregrine Douglas Gonzague Riviere come amministratore in data 01 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
EVANS, David Nigel | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 134975040001 | ||||||||
MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 173703620001 | ||||||||
BUNTER, Nigel Stephen Gilmore | Segretario | 3 Poughcombe Cottages Ogbourne St. Andrew SN8 1SE Marlborough Wiltshire | British | Company Director | 69955750001 | |||||||||
DAVIS, Clive Clayton | Segretario | Hill Farm House Little Rissington GL54 2NA Cheltenham Gloucestershie | British | 92013820001 | ||||||||||
EMETULU, Lola | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
WRIGHT, Garth Howard | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire England | British | 130769810001 | ||||||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||||||
ALLEN, Christian Philip Quentin | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 123612980001 | |||||||||
BREWER, Stephen | Amministratore | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | Company Director | 79186090002 | |||||||||
BROCKLEHURST, Nigel | Amministratore | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | Director | 83126790001 | |||||||||
BUNTER, Nigel Stephen Gilmore | Amministratore | 3 Poughcombe Cottages Ogbourne St. Andrew SN8 1SE Marlborough Wiltshire | British | Company Director | 69955750001 | |||||||||
CHESWORTH, Paul | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 99525280001 | |||||||||
DARBY, Gavin John | Amministratore | Rodona House Rodona Road St Georges Hill KT13 0NP Weybridge Surrey | England | British | Director | 99277850001 | ||||||||
DAVIS, Clive Clayton | Amministratore | Hill Farm House Little Rissington GL54 2NA Cheltenham Gloucestershie | British | Chartered Accountant | 92013820001 | |||||||||
DEV, Vivek | Amministratore | Connought House Ledborough Gate Ledborough Lane HP9 2DQ Beaconsfield | British | Chartered Accountant | 79178710001 | |||||||||
EVANS, Mark | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Chief Financial Officer | 127017870001 | |||||||||
FINCH, Joanne Sarah | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Senior Finance Manager | 158146620001 | ||||||||
GALLI, Diego | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | Company Director | 171566420001 | ||||||||
HARRIS, Brian Athol | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | Australian | Head Of Enterprise Finance | 135937300001 | ||||||||
KNIGHT, Nigel Phillip | Amministratore | The Old Barn, Formby Hall Southport Old Road, Formby L37 0AB Liverpool Merseyside | British | Company Director | 70898900001 | |||||||||
LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | Director | 24471140001 | ||||||||
LEE, Richard Ashleigh | Amministratore | 29 Cheyne Walk Chelsea SW3 5HH London | United Kingdom | British | Company Director | 11980050001 | ||||||||
LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
LOGAN, Hugh | Amministratore | 7 Tresham Drive Grappenhall WA4 3DU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | M.D. | 119332280001 | ||||||||
MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 173703620001 | ||||||||
MOFFAT, Simon Alexander | Amministratore | Greyfriars 17 Pony Chase KT11 2PF Cobham Surrey | British | Finance Director | 41139540002 | |||||||||
NOWAK, Thomas, Dr | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | Director | 174443800001 | ||||||||
PURKESS, Martin John | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | Director | 139360020001 | ||||||||
QADRI, Sohail | Amministratore | 122 Somerset Road Wimbledon SW19 5HP London | British | Manager | 52341900001 | |||||||||
READ, Nicholas Jonathan | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 87149560001 | ||||||||
RIVIERE, Peregrine Douglas Gonzague | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | Director | 207135750001 | ||||||||
SCHA*FER, Richard Wolfgang Henry | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance Technology & Support | 150941520001 | ||||||||
TOURNON, Emanuele | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | Director | 103542080002 | ||||||||
TOWNSEND, John Raymond | Amministratore | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | Financial Director | 95223480001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CELLULAR OPERATIONS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellops Limited | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Vodafone Uk Limited | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CELLULAR OPERATIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creato il 22 gen 2003 Consegnato il 08 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h property k/a sites 1 and 2 and the land at the north side of peatmoor way hillmead t/n WT177342 and WT190205. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 22 gen 2003 Consegnato il 08 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h property k/a sites 1 and 2 and the land at the north side of peatmoor way hillmead t/n WT177342 and WT190205. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge (the supplemental charge) which is supplemental to a deed of charge made on 11 may 2000 between the company and vodafone limited | Creato il 16 feb 2001 Consegnato il 05 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 29 ago 2000 Consegnato il 15 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of a service provider agreement dated 28 june 2000 | |
Brevi particolari First fixed charge all claims choses in action intellectual property goodwill under the service provider agreement and all book debts; floating charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 11 mag 2000 Consegnato il 27 mag 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreement of even date | |
Brevi particolari First fixed charge choses in action intellectual property goodwill and alll book debts; floating charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 30 mar 1999 Consegnato il 01 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Computer equipment/telephone system as per goods listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Second legal charge | Creato il 01 mar 1999 Consegnato il 17 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as set out in clause 21 and schedule 4 of a development agreement dated 10.12.1998 (as defined),payments from the building contractor relating to the office development of the premises charged,fees of ec harris and curona designs limited in connection with the said development and any additional amounts payable under the agreement dated 10.12.1998 | |
Brevi particolari F/Hold land at hillmead way,swindon,wiltshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of security assignment and agreement | Creato il 23 feb 1999 Consegnato il 12 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreements (as defined) | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and all benefits to accrue to it in respect of the building contract, the parent company guarantee, the appointments and the performance bond under the first deed of assignment and the development agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 26 nov 1998 Consegnato il 08 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 20 nov 1998 Consegnato il 11 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a site off meadway hillmead enterprise park swindon wiltshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deposit deed | Creato il 03 lug 1998 Consegnato il 09 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two leases both of even date | |
Brevi particolari A deposit of £138,000 held by the chargee with lloyds bank PLC covent garden branch. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 27 mar 1997 Consegnato il 04 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to airtime charges | |
Brevi particolari Second fixed and floating charge over custoner recievables. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 mar 1997 Consegnato il 04 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 27TH march 1997 | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0