SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03234367
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEGISLATOR 1288 LIMITED06 ago 199606 ago 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ago 2012

    Stato del capitale al 14 ago 2012

    • Capitale: GBP 1,080,000
    SH01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    29 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    25 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305920001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    O`REILLY, John
    35a Court Farm Road
    UB5 5HQ Northolt
    Middlesex
    Segretario
    35a Court Farm Road
    UB5 5HQ Northolt
    Middlesex
    British48337750001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Segretario
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    English51896650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    STEVEN, Kenneth
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    Segretario
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    British64425700001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Amministratore
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Amministratore
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MARSHALL, Diana Jane
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    Amministratore
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    British47799990002
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    EnglandEnglish51896650001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Amministratore
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Amministratore
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritish124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STABLES, Trevor Leslie
    Sakura 9 Kingsmeadow
    Crudwell
    SN16 9HT Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Sakura 9 Kingsmeadow
    Crudwell
    SN16 9HT Malmesbury
    Wiltshire
    British51294380001
    STEVEN, Kenneth
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    British64425700001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 ago 2002
    Consegnato il 03 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 03 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed relating to rent deposit
    Creato il 28 lug 1997
    Consegnato il 31 lug 1997
    In corso
    Importo garantito
    The rents due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 28TH july 1997 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of this deed
    Brevi particolari
    As a continuing security the account and the deposit sum being £32,400.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 31 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed relating to rent deposit
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 18 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies now due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date and this charge
    Brevi particolari
    The sum of £62,415 including such further moneys as shall be demanded or payable under the deed all amounts from time to time standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 18 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All moneys debts and liabilities due or to become due from the company or any other group company to the chargee pursuant to the terms of the charge and any group releveant document (as defined)
    Brevi particolari
    The l/h interest in the scheduled property and all rights relating to the schedule property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (SOUTH EAST) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0