ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED

ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàECD (COOKHAM WOOD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03241233
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
    • Istruzione secondaria tecnica e professionale (85320) / Istruzione

    Dove si trova ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Chris Burlton il 26 gen 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ a C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane Bristol BS1 6NA in data 15 giu 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 mag 2017

    LRESSP

    Dettagli del segretario cambiati per Semperian Secretariat Services Limited il 19 mag 2017

    1 pagineCH04

    Cessazione della carica di Alan Campbell Ritchie come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 giu 2016

    Stato del capitale al 28 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Paul Roger Cook come amministratore in data 18 mag 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gawie Murray Nienaber come amministratore in data 18 mag 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Parker come amministratore in data 18 mag 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vaishali Jagdish Patel come amministratore in data 18 mag 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 ago 2015

    Stato del capitale al 24 ago 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Roger Cook il 01 lug 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    18 pagineAA

    Nomina di Mr Chris Burlton come amministratore in data 02 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Vaishali Jagdish Patel come amministratore in data 17 nov 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    107624260005
    BURLTON, Chris
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish191923330001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Segretario
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BARLOW, Suzanne
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    Segretario
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    British49252810001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Segretario
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    British52429400001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Amministratore
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BANKS, Andrew David
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish164295230001
    BIRCH, Alan Edward
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish90700330001
    BIRCH, Alan Edward
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish90700330001
    BROWN, Matthew Charles
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Amministratore
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish181465860001
    BROWN, Stephen Richard
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    Amministratore
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    British15085940005
    COOK, Paul Roger
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Amministratore
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    UkBritish117120110001
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Amministratore
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Amministratore
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    ELLIOTT, Christopher
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish64082070001
    FARLEY, Graham
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    Amministratore
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    United KingdomBritish183764380001
    GILBEY, Hannah
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British78180430001
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Amministratore
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    HARROWER, James Arthur
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    Amministratore
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    British12257110001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Amministratore
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Amministratore
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    JONES, Stuart Nigel
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    British79744320001
    LAVERS, Michael John
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    Amministratore
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    EnglandBritish3090450001
    MALMBERG, Louis Joannes
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Amministratore
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Dutch45086130001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Amministratore
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Amministratore
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MORGAN, David Keir Ewart
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Amministratore
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish106484320002
    MORRIS, Richard
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish159675380001
    NIENABER, Gawie Murray
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    Amministratore
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    EnglandBritish187146260001
    OSBORNE, Robert Charles
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    Amministratore
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    British68448420001
    PARKER, John
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    Amministratore
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    United KingdomEnglish182836610001
    PATEL, Vaishali Jagdish
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Amministratore
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    United KingdomBritish192721880001
    PELLARD, Brian
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33408310001

    ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 24 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a cookham wood secure training centre cookham wood rochester kent.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transazioni
    • 24 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental fixed charge
    Creato il 31 gen 2002
    Consegnato il 20 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the equipment including all moneyspayable and the proceeds of any claims awards or judgements together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department (Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Whole or in Part and Whether at Law or in Equity)
    Transazioni
    • 20 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 31 gen 2002
    Consegnato il 20 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sums payable by her majesty's principal secretary of state for the home department (the "authority") to the company pursuant to schedule u of an agreement (the "dcmf contract") dated 3RD march 1997 between the mortgagor and the authority for the design construction maintenance and operation of a secure training centre at medway kent.
    Persone aventi diritto
    • Carillion Construction Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge debenture
    Creato il 03 mar 1997
    Consegnato il 10 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any banks financing document
    Brevi particolari
    .Leasehold property known as cookham wood, rochester, kent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Bank Secured Creditors)
    Transazioni
    • 10 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1997
    Consegnato il 10 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or connection with any banks financing document
    Brevi particolari
    All that leasehold property knoen as cookham wood secure training centre, cookham wood, rochester, kent.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Banks Secured Creditors)
    Transazioni
    • 10 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of fixed charge
    Creato il 03 mar 1997
    Consegnato il 08 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligation of the company owed to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement dated 3RD march 1997 between the chargee and the company (as therein defined) ("the dcmf contract") to transfer title to the equipment (as therein defined) upon termination of the "dcmf contract" together with any damages payable by the company to the chargee by reason of a failure to comply with clause 17.2 of the "dcmf contract"
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest (present and future) to and in the equipment being all the property referred to in schedule b of the dcmf contract and all the plant machinery and other equipment referred to in schedule a of the dcmf contract by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department(Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Wholeor in Part and Whether at Law or in Equity)
    Transazioni
    • 08 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 mag 2017Inizio della liquidazione
    02 mag 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gilbert J Lemon
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Praticante
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Richard Lewis
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Praticante
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0