ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03241233 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
- Istruzione secondaria tecnica e professionale (85320) / Istruzione
Dove si trova ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane BS1 6NA Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Chris Burlton il 26 gen 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ a C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane Bristol BS1 6NA in data 15 giu 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Semperian Secretariat Services Limited il 19 mag 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Campbell Ritchie come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Roger Cook come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gawie Murray Nienaber come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Parker come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vaishali Jagdish Patel come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Roger Cook il 01 lug 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Chris Burlton come amministratore in data 02 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Vaishali Jagdish Patel come amministratore in data 17 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | 1 Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor United Kingdom | 107624260005 | |||||||
| BURLTON, Chris | Amministratore | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 191923330001 | |||||
| ANDERSON, David Alexander John | Segretario | 4 Elm Tree Avenue KT10 8JG Esher Surrey | British | 94497310001 | ||||||
| BARLOW, Suzanne | Segretario | 22 Monteagle Drive DY6 7RY Kingswinford West Midlands | British | 49252810001 | ||||||
| HERZBERG, Francis Robin | Segretario | Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted 6 Hertfordshire | British | 52429400001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| ANDERSON, David Alexander John | Amministratore | 4 Elm Tree Avenue KT10 8JG Esher Surrey | British | 94497310001 | ||||||
| BANKS, Andrew David | Amministratore | St. Marys Cowl Lane, Winchcombe GL54 5RA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 164295230001 | |||||
| BIRCH, Alan Edward | Amministratore | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||
| BIRCH, Alan Edward | Amministratore | 7 Silsbury Grove Standish WN6 0EY Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||
| BROWN, Matthew Charles | Amministratore | Southside 105 Victoria Street SW1E 6QT London G4s England England | England | British | 181465860001 | |||||
| BROWN, Stephen Richard | Amministratore | 8 Arbour Close GL55 6RR Mickleton Gloucestershire | British | 15085940005 | ||||||
| COOK, Paul Roger | Amministratore | 105 Victoria St SW1E 6QT London Southside United Kingdom | Uk | British | 117120110001 | |||||
| DALGLEISH, Bruce Warren | Amministratore | Post Box House Abinger Road RH5 6HD Coldharbour Surrey | United Kingdom | British | 106281140002 | |||||
| DALGLEISH, Bruce Warren | Amministratore | Post Box House Abinger Road RH5 6HD Coldharbour Surrey | United Kingdom | British | 106281140002 | |||||
| ELLIOTT, Christopher | Amministratore | Woodcote House Broad Lane Bishampton WR10 2LY Pershore Worcestershire | England | British | 64082070001 | |||||
| FARLEY, Graham | Amministratore | 9 Manor Close Hinstock TF9 2TZ Market Drayton Salop | United Kingdom | British | 183764380001 | |||||
| GILBEY, Hannah | Amministratore | 14 Dane Park CM23 2PR Bishops Stortford Hertfordshire | British | 78180430001 | ||||||
| GIRLING, Christopher Francis | Amministratore | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| HARROWER, James Arthur | Amministratore | 24 Lifford Gardens WR12 7DA Broadway Worcestershire | British | 12257110001 | ||||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted 6 Hertfordshire | England | British | 52429400001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted 6 Hertfordshire | England | British | 52429400001 | |||||
| JONES, Stuart Nigel | Amministratore | 23 Old Farm Drive Codsall WV8 1GF Wolverhampton West Midlands | British | 79744320001 | ||||||
| LAVERS, Michael John | Amministratore | 2 Binden Road W12 9RJ London | England | British | 3090450001 | |||||
| MALMBERG, Louis Joannes | Amministratore | Scheveningseslag 87 2586 KW The Hague Netherlands | Dutch | 45086130001 | ||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Amministratore | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCCULLOCH, Paul | Amministratore | 33 Southwood Avenue Highgate N6 5SA London | British | 101810930001 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Amministratore | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MORGAN, David Keir Ewart | Amministratore | Care And Justice 5th Floor, Southside 105 Victoria Street SW1E 6QT London G4s England England | England | British | 106484320002 | |||||
| MORRIS, Richard | Amministratore | Old Park Lane M41 7HA Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 159675380001 | |||||
| NIENABER, Gawie Murray | Amministratore | 105 Victoria St SW1E 6QT London Southside England England | England | British | 187146260001 | |||||
| OSBORNE, Robert Charles | Amministratore | Heath View Bromstead Common TF10 9DG Newport Shropshire | British | 68448420001 | ||||||
| PARKER, John | Amministratore | Chalgrove Field Oakhill MK5 6AJ Milton Keynes Oakhill Stc England England | United Kingdom | English | 182836610001 | |||||
| PATEL, Vaishali Jagdish | Amministratore | 105 Victoria St SW1E 6QT London Southside United Kingdom | United Kingdom | British | 192721880001 | |||||
| PELLARD, Brian | Amministratore | 33 Wyvern Road B74 2PS Sutton Coldfield West Midlands | British | 33408310001 |
ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 19 nov 2004 Consegnato il 24 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property k/a cookham wood secure training centre cookham wood rochester kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental fixed charge | Creato il 31 gen 2002 Consegnato il 20 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the equipment including all moneyspayable and the proceeds of any claims awards or judgements together with interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 31 gen 2002 Consegnato il 20 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The sums payable by her majesty's principal secretary of state for the home department (the "authority") to the company pursuant to schedule u of an agreement (the "dcmf contract") dated 3RD march 1997 between the mortgagor and the authority for the design construction maintenance and operation of a secure training centre at medway kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge debenture | Creato il 03 mar 1997 Consegnato il 10 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any banks financing document | |
Brevi particolari .Leasehold property known as cookham wood, rochester, kent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 mar 1997 Consegnato il 10 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or connection with any banks financing document | |
Brevi particolari All that leasehold property knoen as cookham wood secure training centre, cookham wood, rochester, kent.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of fixed charge | Creato il 03 mar 1997 Consegnato il 08 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligation of the company owed to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement dated 3RD march 1997 between the chargee and the company (as therein defined) ("the dcmf contract") to transfer title to the equipment (as therein defined) upon termination of the "dcmf contract" together with any damages payable by the company to the chargee by reason of a failure to comply with clause 17.2 of the "dcmf contract" | |
Brevi particolari All the company's right title and interest (present and future) to and in the equipment being all the property referred to in schedule b of the dcmf contract and all the plant machinery and other equipment referred to in schedule a of the dcmf contract by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0