ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED

ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03242996
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HYDREX GROUP LIMITED14 mar 199714 mar 1997
    FILBUK 416 LIMITED28 ago 199628 ago 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 nov 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ott 2011

    Stato del capitale al 19 ott 2011

    • Capitale: GBP 582,162.5
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Carl Mark D'ammassa il 28 ago 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan James Jordan il 28 ago 2011

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 30 giu 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Alan James Jordan come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Wood come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Wood come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    35 pagineMG01

    Nomina di Mr Carl Mark D'ammassa come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Simcox come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    16 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Chi sono gli amministratori di ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    D'AMMASSA, Carl Mark
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    Amministratore
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    United KingdomBritish147037660007
    JORDAN, Alan James
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    Amministratore
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    EnglandIrish150320720001
    BOYD, Steven Clive
    Martins Nest
    West Kington
    SN14 7JE Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Martins Nest
    West Kington
    SN14 7JE Chippenham
    Wiltshire
    British70337230001
    DAVIES, Irona Wendy
    Woodbridge Beachley Road
    Tutshill
    NP6 7DL Chepstow
    Gwent
    Segretario
    Woodbridge Beachley Road
    Tutshill
    NP6 7DL Chepstow
    Gwent
    British2207330001
    SEYMOUR, Paul Richard
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    Segretario
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    British75293670002
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Segretario
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    British33951380003
    FILBUK (SECRETARIES) LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004990001
    BOYD, Steven Clive
    Martins Nest
    West Kington
    SN14 7JE Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Martins Nest
    West Kington
    SN14 7JE Chippenham
    Wiltshire
    British70337230001
    DAVIES, Brian Thomas
    Woodbridge
    Rockvilla Lane Beachley Road
    NP6 2DR Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    Woodbridge
    Rockvilla Lane Beachley Road
    NP6 2DR Chepstow
    Gwent
    United KingdomBritish39854170001
    GADOROS, Bela
    63 Gaston Bridge Road
    TW17 8HF Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    63 Gaston Bridge Road
    TW17 8HF Shepperton
    Middlesex
    British20061270001
    GREENALL, Andrew Mclaren
    4 Greenway
    SG6 3UG Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Greenway
    SG6 3UG Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    U.KBritish108417750003
    ROBY, Stephen Alec
    7 Brook Lane
    Catcott
    TA7 9HG Bridgwater
    Greenacres
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    7 Brook Lane
    Catcott
    TA7 9HG Bridgwater
    Greenacres
    Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritish64440220002
    ROGERS, Douglas Ernest
    Kiln House 5 Kiln Lane
    Shirley
    B90 1SF Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Kiln House 5 Kiln Lane
    Shirley
    B90 1SF Solihull
    West Midlands
    British32445690008
    SIMCOX, Andrew James
    Ashley Drive South
    Ashley Heath
    BH24 2JP Ringwood
    53
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Drive South
    Ashley Heath
    BH24 2JP Ringwood
    53
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish41023640002
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Amministratore
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    United KingdomBritish33951380003
    FILBUK NOMINEES LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore delegato nominato
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004980001

    ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2006
    Consegnato il 23 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 mar 2005
    Consegnato il 17 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 17 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002
    Creato il 06 mag 2003
    Consegnato il 09 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the hydrex limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The words "and as further amended by way of supplemental agreement dated 6 may 2003 shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002
    Creato il 21 feb 2003
    Consegnato il 13 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The following amendments shall be made to the debenture the words "as amended by way of a side letter produced by osborne clarke dated 20 february 2003" shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed" save as amended above the terms of the debenture shall remain in full force and effect.
    Persone aventi diritto
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 13 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 12 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to becomne due from the company, hydrex limited and any of their subsidiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the following assets and rights :- the equipment, the contracts, conditions warranties and agreements, documents, all insurances and any monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company formerly known as filbuk 416 limited or any of the borrowers to the chargee and/or pursuant to any of the financing documents (the secured obligations)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 feb 1997
    Consegnato il 17 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0