TD PACKAGING LIMITED

TD PACKAGING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTD PACKAGING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03243491
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TD PACKAGING LIMITED?

    • Attività di imballaggio (82920) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova TD PACKAGING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TD PACKAGING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BORDERS PACKAGING LIMITED29 ago 199629 ago 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di TD PACKAGING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per TD PACKAGING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Andrew Martin Morrow come segretario in data 15 ott 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Damien Moynagh come segretario in data 15 ott 2021

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    14 pagineAA

    Nomina di Alison Richardson come amministratore in data 24 set 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Birtles come amministratore in data 24 set 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    13 pagineAA

    Nomina di Mr David Birtles come amministratore in data 01 ott 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Louise Tallon come amministratore in data 01 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Ralph come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sean Gerard Coyle come amministratore in data 26 set 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Damien Moynagh come segretario in data 03 mag 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tara Grimley come segretario in data 03 mag 2017

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Gannon come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TD PACKAGING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORROW, Andrew Martin
    Church Way
    N20 0LA London
    30
    United Kingdom
    Segretario
    Church Way
    N20 0LA London
    30
    United Kingdom
    288464390001
    RICHARDSON, Alison
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Amministratore
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    EnglandBritish251246230001
    TALLON, Louise
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish251371350001
    DALY, Barbara
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    British49255000003
    DALY, Mark Shaun
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    British49254940003
    GANNON, Michael
    Stillorgan Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    7
    Ireland
    Segretario
    Stillorgan Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    7
    Ireland
    177394180001
    GEOGHEGAN, Karen
    8 Woodstown Parade
    16 Knocklyon
    Dublin
    Ireland
    Segretario
    8 Woodstown Parade
    16 Knocklyon
    Dublin
    Ireland
    Irish126163560001
    GOUGH, Philip
    17 Badgers Brook
    Wroughton
    SN4 9DG Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    17 Badgers Brook
    Wroughton
    SN4 9DG Swindon
    Wiltshire
    British103829140002
    GRIMLEY, Tara
    Linseys Hill
    BT61 9HD Armagh
    34
    Northern Ireland
    Segretario
    Linseys Hill
    BT61 9HD Armagh
    34
    Northern Ireland
    188265530001
    MOYNAGH, Damien
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Segretario
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    231205960001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BIRTLES, David Warren
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Amministratore
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    United KingdomBritish251208900001
    CLOW, Karen Susan
    Sanctuary Cottage Upper Lynch Road
    France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Sanctuary Cottage Upper Lynch Road
    France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British52324430002
    COYLE, Sean Gerard
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Amministratore
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    IrelandIrish253248680001
    DALY, Mark Shaun
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    British49254940003
    FITZGERALD, Liam Michael
    32 Grosvenor Road
    IRISH Rathgar
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    32 Grosvenor Road
    IRISH Rathgar
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish70358960003
    FLYNN, Annette
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    Amministratore
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    IrishIrish153801960001
    GANNON, Michael
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    Amministratore
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    IrelandIrish281260700001
    MCGRANE, Barry
    72 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    IRISH Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    72 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    IRISH Dublin 6
    Ireland
    Irish76789920001
    RALPH, Alan
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Amministratore
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    IrelandIrish168997940001
    SCOTT, Enda John
    Magna Business Park
    Citywest Road
    Dublin
    United Drug House Magna Drive
    24
    Ireland
    Amministratore
    Magna Business Park
    Citywest Road
    Dublin
    United Drug House Magna Drive
    24
    Ireland
    EnglandIrish172282060001
    TEDHAM, Martin John
    South Farm
    Chiseldon
    SN4 0JF Swindon
    Mulburry House
    Wiltshire
    Amministratore
    South Farm
    Chiseldon
    SN4 0JF Swindon
    Mulburry House
    Wiltshire
    EnglandBritish139879690001
    VAN BIJLEVELD, Anthonius Jan
    PO BOX 713
    As Heerenveen
    European Packaging Centre
    8440
    Netherlands
    Amministratore
    PO BOX 713
    As Heerenveen
    European Packaging Centre
    8440
    Netherlands
    NetherlandsDutch153801410001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TD PACKAGING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Udg Healthcare (Uk) Holdings Limited
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    England
    06 apr 2016
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2012
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione3384213
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    TD PACKAGING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 19 mag 2005
    Consegnato il 21 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The chattels being 1 x edl john quinn packaging EVP5025 sleeve wrapper serial no 88044 (0013), 1 x pals FL30SWLR 1.8M labeller serial no 175941 (0024), 1 x pals FL30SWLL 1.8M labeller serial no 156030 (0037), for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 apr 2005
    Consegnato il 18 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 18 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease
    Brevi particolari
    The tenant with full title guarantee has charged its interest in the deposit being the sum of £16,750.00 and all interest and other monies paid or credited to the deposit account or paid by the company to the chargee pursuant to the deed.
    Persone aventi diritto
    • Winterthur Life UK Limited
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 21 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various chattels under the mortgage bearing reference number 258-092218-17 dated 17TH december 1999. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 dic 1999
    Consegnato il 22 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 mar 1999
    Consegnato il 18 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts present and future as are not sold to and bought by alex. Lawrie receivables financing limited under an agreement dated 16TH march 1999 and by way of floating charge on all proceeds thereof either under or in connection with any agreement or contract at any time subsisting between the company and alex. Lawrie receivables financing for the sale and purchase of debts under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which the company and alex. Lawrie recievables financing limited are parties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 18 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 giu 1997
    Consegnato il 24 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brevi particolari
    £6,462.50 and interest.
    Persone aventi diritto
    • Courts PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0