TD PACKAGING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TD PACKAGING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03243491 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TD PACKAGING LIMITED?
- Attività di imballaggio (82920) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova TD PACKAGING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ashfield House Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Leicestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TD PACKAGING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BORDERS PACKAGING LIMITED | 29 ago 1996 | 29 ago 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TD PACKAGING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per TD PACKAGING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Nomina di Andrew Martin Morrow come segretario in data 15 ott 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Damien Moynagh come segretario in data 15 ott 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2020 | 14 pagine | AA | ||
Nomina di Alison Richardson come amministratore in data 24 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di David Birtles come amministratore in data 24 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 13 pagine | AA | ||
Nomina di Mr David Birtles come amministratore in data 01 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Louise Tallon come amministratore in data 01 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Alan Ralph come amministratore in data 01 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Sean Gerard Coyle come amministratore in data 26 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 15 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Damien Moynagh come segretario in data 03 mag 2017 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Tara Grimley come segretario in data 03 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Michael Gannon come amministratore in data 30 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di TD PACKAGING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORROW, Andrew Martin | Segretario | Church Way N20 0LA London 30 United Kingdom | 288464390001 | |||||||
| RICHARDSON, Alison | Amministratore | Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Ashfield House Leicestershire | England | British | 251246230001 | |||||
| TALLON, Louise | Amministratore | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 20 Dublin Ireland | Ireland | Irish | 251371350001 | |||||
| DALY, Barbara | Segretario | 19 High Street Cricklade SN6 6AP Swindon Wiltshire | British | 49255000003 | ||||||
| DALY, Mark Shaun | Segretario | 19 High Street Cricklade SN6 6AP Swindon Wiltshire | British | 49254940003 | ||||||
| GANNON, Michael | Segretario | Stillorgan Park Blackrock Co. Dublin 7 Ireland | 177394180001 | |||||||
| GEOGHEGAN, Karen | Segretario | 8 Woodstown Parade 16 Knocklyon Dublin Ireland | Irish | 126163560001 | ||||||
| GOUGH, Philip | Segretario | 17 Badgers Brook Wroughton SN4 9DG Swindon Wiltshire | British | 103829140002 | ||||||
| GRIMLEY, Tara | Segretario | Linseys Hill BT61 9HD Armagh 34 Northern Ireland | 188265530001 | |||||||
| MOYNAGH, Damien | Segretario | Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Ashfield House Leicestershire | 231205960001 | |||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| BIRTLES, David Warren | Amministratore | Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Ashfield House Leicestershire | United Kingdom | British | 251208900001 | |||||
| CLOW, Karen Susan | Amministratore | Sanctuary Cottage Upper Lynch Road France Lynch GL6 8LZ Stroud Gloucestershire | British | 52324430002 | ||||||
| COYLE, Sean Gerard | Amministratore | Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Ashfield House Leicestershire | Ireland | Irish | 253248680001 | |||||
| DALY, Mark Shaun | Amministratore | 19 High Street Cricklade SN6 6AP Swindon Wiltshire | British | 49254940003 | ||||||
| FITZGERALD, Liam Michael | Amministratore | 32 Grosvenor Road IRISH Rathgar Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 70358960003 | |||||
| FLYNN, Annette | Amministratore | Magna Drive Magna Business Park Citywest Road United Drug House Dublin 24 Ireland | Irish | Irish | 153801960001 | |||||
| GANNON, Michael | Amministratore | Magna Drive Magna Business Park Citywest Road United Drug House Dublin 24 Ireland | Ireland | Irish | 281260700001 | |||||
| MCGRANE, Barry | Amministratore | 72 Holywell Upper Kilmacud Road IRISH Dublin 6 Ireland | Irish | 76789920001 | ||||||
| RALPH, Alan | Amministratore | Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Ashfield House Leicestershire | Ireland | Irish | 168997940001 | |||||
| SCOTT, Enda John | Amministratore | Magna Business Park Citywest Road Dublin United Drug House Magna Drive 24 Ireland | England | Irish | 172282060001 | |||||
| TEDHAM, Martin John | Amministratore | South Farm Chiseldon SN4 0JF Swindon Mulburry House Wiltshire | England | British | 139879690001 | |||||
| VAN BIJLEVELD, Anthonius Jan | Amministratore | PO BOX 713 As Heerenveen European Packaging Centre 8440 Netherlands | Netherlands | Dutch | 153801410001 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TD PACKAGING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udg Healthcare (Uk) Holdings Limited | 06 apr 2016 | Resolution Road LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch Ashfield House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TD PACKAGING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Chattel mortgage | Creato il 19 mag 2005 Consegnato il 21 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The chattels being 1 x edl john quinn packaging EVP5025 sleeve wrapper serial no 88044 (0013), 1 x pals FL30SWLR 1.8M labeller serial no 175941 (0024), 1 x pals FL30SWLL 1.8M labeller serial no 156030 (0037), for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 01 apr 2005 Consegnato il 18 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent security deposit deed | Creato il 27 set 2001 Consegnato il 09 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease | |
Brevi particolari The tenant with full title guarantee has charged its interest in the deposit being the sum of £16,750.00 and all interest and other monies paid or credited to the deposit account or paid by the company to the chargee pursuant to the deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 17 dic 1999 Consegnato il 21 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Various chattels under the mortgage bearing reference number 258-092218-17 dated 17TH december 1999. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 08 dic 1999 Consegnato il 22 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 16 mar 1999 Consegnato il 18 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari First fixed charge on all book debts and other debts present and future as are not sold to and bought by alex. Lawrie receivables financing limited under an agreement dated 16TH march 1999 and by way of floating charge on all proceeds thereof either under or in connection with any agreement or contract at any time subsisting between the company and alex. Lawrie receivables financing for the sale and purchase of debts under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which the company and alex. Lawrie recievables financing limited are parties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 18 giu 1997 Consegnato il 24 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Brevi particolari £6,462.50 and interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0