DG3 EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDG3 EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03243754
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DG3 EUROPE LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DG3 EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DG3 EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CGI EUROPE LIMITED19 feb 200419 feb 2004
    CUNNINGHAM GRAPHICS INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED24 nov 199924 nov 1999
    RODA LIMITED20 nov 199620 nov 1996
    MUNDAYS (586) LIMITED29 ago 199629 ago 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di DG3 EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per DG3 EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Jeremy Edward Charles Walters come amministratore in data 01 dic 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Babat come amministratore in data 01 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Laurent Thierry Salmon come amministratore in data 01 dic 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gary Ronald Wilson come amministratore in data 01 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Patrick James Crean come amministratore in data 01 dic 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Roth come amministratore in data 01 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Joseph Cahill come segretario in data 01 dic 2021

    2 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da Fourth Floor Abbots House Abbey Street Reading Berkshire RG1 3BD a Lower Ground Floor, Park House, 16/18 Finsbury Circus London EC2M 7EB in data 02 dic 2021

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 032437540008 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Michael Roth come amministratore in data 19 nov 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gary Ronald Wilson come amministratore in data 08 lug 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Suzanne Latouche come amministratore in data 19 nov 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Barry James Page come amministratore in data 17 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Suzanne Latouche come amministratore in data 17 giu 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di DG3 EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAHILL, Richard Joseph
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16-18
    England
    Segretario
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16-18
    England
    290126540001
    CREAN, Patrick James
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    Amministratore
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    United KingdomIrish54812330034
    SALMON, Laurent Thierry
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    Amministratore
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    FranceFrench99803370004
    WALTERS, Jeremy Edward Charles
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    Amministratore
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    EnglandBritish234484880013
    JEAL, Paul William
    2 Millharbour
    E14 9TE Docklands
    Unit C3 Enterprise Business Park
    London
    England
    Segretario
    2 Millharbour
    E14 9TE Docklands
    Unit C3 Enterprise Business Park
    London
    England
    British152795690001
    RIDGEON, Marie
    Woodeaves
    Yester Park
    BR7 5DQ Chislehurst
    Kent
    Segretario
    Woodeaves
    Yester Park
    BR7 5DQ Chislehurst
    Kent
    British63910120006
    MUNDAYS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Crown House
    Church Road Claygate
    KT10 0LP Esher
    Surrey
    Segretario
    Crown House
    Church Road Claygate
    KT10 0LP Esher
    Surrey
    41120340001
    BABAT, Steven
    Burma Road
    07305 Jersey City
    100
    New Jersey
    United States
    Amministratore
    Burma Road
    07305 Jersey City
    100
    New Jersey
    United States
    United StatesAmerican243416130002
    BENSON, James Bracken
    110 Riverside Drive
    New York New York 10024
    Usa
    Amministratore
    110 Riverside Drive
    New York New York 10024
    Usa
    American49951550001
    CROFT, John Phillip Kemble
    Hainton Lodge
    OX14 4AX Sutton Courtenay
    Oxfordshire
    Amministratore
    Hainton Lodge
    OX14 4AX Sutton Courtenay
    Oxfordshire
    EnglandBritish177392380001
    CUNNINGHAM, Michael
    10 Longview Road
    Lebanon
    08833 New Jersey
    America
    Amministratore
    10 Longview Road
    Lebanon
    08833 New Jersey
    America
    American59835810001
    DOUVILLE, Richard Alan
    47 Corey Lane
    FOREIGN Mendham
    New Jersey Nj 07945
    Usa
    Amministratore
    47 Corey Lane
    FOREIGN Mendham
    New Jersey Nj 07945
    Usa
    American79710390001
    ELMAN, Ralph Julian
    Graces Mews
    Abbey Road
    NW8 9AZ London
    8
    Amministratore
    Graces Mews
    Abbey Road
    NW8 9AZ London
    8
    United KingdomBritish80068050004
    FURLONGE, Peter Lionel
    Chequers Lane
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11, Thames Gateway Park
    England
    England
    Amministratore
    Chequers Lane
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11, Thames Gateway Park
    England
    England
    EnglandBritish181687720002
    FURLONGE, Peter Lionel
    Flat 4 Princes Tower
    Elephant Lane
    SE16 4NF London
    Amministratore
    Flat 4 Princes Tower
    Elephant Lane
    SE16 4NF London
    United KingdomBritish25494790002
    HARVEY, William George Barnet
    Mountford House 25 Britton Street
    EC1M 5NY London
    Amministratore
    Mountford House 25 Britton Street
    EC1M 5NY London
    British4993280001
    HARVEY, William George Barnet
    Mountford House 25 Britton Street
    EC1M 5NY London
    Amministratore
    Mountford House 25 Britton Street
    EC1M 5NY London
    British4993280001
    JEAL, Paul William
    Enterprise Business Park
    2 Millharbour, Docklands
    E14 9TE London
    Unit C3
    England
    Amministratore
    Enterprise Business Park
    2 Millharbour, Docklands
    E14 9TE London
    Unit C3
    England
    EnglandBritish133821720002
    LATOUCHE, Suzanne
    Chequers Lane
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11, Thames Gateway Park
    England
    England
    Amministratore
    Chequers Lane
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11, Thames Gateway Park
    England
    England
    United KingdomBritish191220420001
    MULLEN, Terence Maxwell
    Park Ave
    30th Floor
    10022 New York
    320
    New York
    Amministratore
    Park Ave
    30th Floor
    10022 New York
    320
    New York
    UsaUnited States96358540001
    MUNDAY, Peter James
    Pinewood Lodge
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Pinewood Lodge
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritish44005460001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Amministratore
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    O'HARE, Robert
    354 Lacey Drive
    New Milford
    07646 New Jersey
    Bergen
    America
    Amministratore
    354 Lacey Drive
    New Milford
    07646 New Jersey
    Bergen
    America
    American59835500001
    PAGE, Barry James
    Thames Gateway Park
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11
    United Kingdom
    Amministratore
    Thames Gateway Park
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11
    United Kingdom
    United KingdomBritish95915770003
    PAGE, Barry James
    Woodlands
    60 Hazelmere Road
    BR5 1PD Pettswood
    Kent
    Amministratore
    Woodlands
    60 Hazelmere Road
    BR5 1PD Pettswood
    Kent
    United KingdomBritish95915770003
    RIDGEON, Marie
    Woodeaves
    Yester Park
    BR7 5DQ Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Woodeaves
    Yester Park
    BR7 5DQ Chislehurst
    Kent
    British63910120006
    ROTH, Michael
    Burma Road
    07305 Jersey City
    100
    New Jersey
    United States
    Amministratore
    Burma Road
    07305 Jersey City
    100
    New Jersey
    United States
    United StatesAmerican265909520001
    SAGGIOMO, Thomas, President & C.E.O.
    Burma Road
    07305 Jersey City
    100
    New Jersey
    United States
    Amministratore
    Burma Road
    07305 Jersey City
    100
    New Jersey
    United States
    Ct UsaBritish149154080001
    SINGER, Robert J
    5 Tanger Drive
    NJ 07039 Livingston
    New Jersey
    Usa
    Amministratore
    5 Tanger Drive
    NJ 07039 Livingston
    New Jersey
    Usa
    Usa79710140001
    WILSON, Gary Ronald
    Chequers Lane
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11, Thames Gateway Park
    England
    England
    Amministratore
    Chequers Lane
    Dagenham Dock
    RM9 6FB London
    Unit 11, Thames Gateway Park
    England
    England
    United KingdomBritish222189880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DG3 EUROPE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Fourth Floor, Abbots House
    Berkshire
    England
    06 apr 2016
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Fourth Floor, Abbots House
    Berkshire
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4949032
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DG3 EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 nov 2016
    Consegnato il 21 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transazioni
    • 21 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 17 feb 2012
    Consegnato il 23 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 16 set 2010
    Consegnato il 18 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 18 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2004
    Consegnato il 05 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 05 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 mar 2004
    Consegnato il 01 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ott 1996
    Consegnato il 05 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £850,000 due from the company to the chargee under the loan notes constituted by an instrument of even date issued by the company
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ralph Julian Elman,Stelby Holdings Limited,Central Investments Limited,the Naggar Familypension Scheme,Mark Lee Tagliaferri and Michaeldavid Moriarty
    Transazioni
    • 05 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ott 1996
    Consegnato il 25 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0