BRITISH CERAMIC TILE LIMITED

BRITISH CERAMIC TILE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITISH CERAMIC TILE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03244910
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    • fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica (23310) / Industrie manifatturiere
    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BCT LIMITED17 apr 199817 apr 1998
    G B C T LIMITED02 set 199602 set 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    42 pagineAM10

    Avviso di termine automatico dell'amministrazione

    34 pagineAM20

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    17 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    43 pagineAM10

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 dic 2018 al 31 mar 2018

    1 pagineAA01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    48 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    16 pagineAM02

    Cessazione della carica di Anthony John Taylor come amministratore in data 19 feb 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Heathfield Newton Abbot Devon TQ12 6RF a 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU in data 18 feb 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Jonathan Rhys David il 17 gen 2019

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Alexander Maculan come amministratore in data 17 gen 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2017 al 29 dic 2017

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 dic 2017

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Shaun David Holmes come amministratore in data 22 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVID, Matthew Jonathan Rhys
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Segretario
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    197175330001
    DAVID, Matthew Jonathan Rhys
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishCertified Accountant176243330002
    KEELING, Natalie Kaye
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishHuman Resources Director205720980002
    STAFFORD-DEITSCH, Andrew
    1 Pembroke Gardens Close
    W8 6HR London
    Amministratore
    1 Pembroke Gardens Close
    W8 6HR London
    EnglandBritishCompany Director153790440001
    WEVILL, Richard Mark, Dr
    Court Wood
    Newton Ferrers
    PL8 1BW Plymouth
    Heron's Reach
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    Court Wood
    Newton Ferrers
    PL8 1BW Plymouth
    Heron's Reach
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritishNon Executive Director120100570002
    BIRD, Michael Thomas
    115 Crabtree Lane
    AL5 5RQ Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    115 Crabtree Lane
    AL5 5RQ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishAccountant437220001
    CHRISTOPHER, Allan John
    Briarfield 5 Kittle Green
    Kittle
    SA3 3JX Swansea
    West Glamorgan
    Segretario
    Briarfield 5 Kittle Green
    Kittle
    SA3 3JX Swansea
    West Glamorgan
    British38193030002
    CLARKSON, James
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Segretario
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    167891010001
    CORDES, Madeleine Ann
    Moor View
    The Street, Roxwell
    CM1 4PA Chelmsford
    Essex
    Segretario
    Moor View
    The Street, Roxwell
    CM1 4PA Chelmsford
    Essex
    British18098540003
    CORKETT, David Alex
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Segretario
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    169925060001
    GAZZARD, Matthew
    1 Pearldene
    Folly Gate
    EX20 3AQ Okehampton
    Devon
    Segretario
    1 Pearldene
    Folly Gate
    EX20 3AQ Okehampton
    Devon
    British90685060002
    EDIS-BATES SECRETARIES LIMITED
    The Croft
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Segretario
    The Croft
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    72611540001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BANTON, David
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Amministratore
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    EnglandBritishManufacturing Director172386890002
    BECHER WICKES, James Nicholas
    65 Pelhams Walk
    KT10 8QA Esher
    Surrey
    Amministratore
    65 Pelhams Walk
    KT10 8QA Esher
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director110374340001
    BIRD, Michael Thomas
    115 Crabtree Lane
    AL5 5RQ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    115 Crabtree Lane
    AL5 5RQ Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant437220001
    CHATER, John James
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Amministratore
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    EnglandBritishCommercial Director128854450001
    CHRISTOPHER, Allan John
    Briarfield 5 Kittle Green
    Kittle
    SA3 3JX Swansea
    West Glamorgan
    Amministratore
    Briarfield 5 Kittle Green
    Kittle
    SA3 3JX Swansea
    West Glamorgan
    WalesBritishAccountant38193030002
    CLARKSON, James Norman
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Amministratore
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    EnglandBritishDirector108928820001
    CORKETT, David Alex
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Amministratore
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    United KingdomBritishDirector103010720002
    DAVISON, Jeremy Robert
    73 Waterside
    EX2 8GY Exeter
    Devon
    Amministratore
    73 Waterside
    EX2 8GY Exeter
    Devon
    BritishCh Accountant65096740005
    EVANS, Carl
    7 Fountain Court
    Abbey Road
    TQ13 9AD Bovey Tracey
    Devon
    Amministratore
    7 Fountain Court
    Abbey Road
    TQ13 9AD Bovey Tracey
    Devon
    BritishDirector84974070001
    EVITT, Timothy Strevens
    15 Barton Close
    Exton
    EX3 0PE Exeter
    Amministratore
    15 Barton Close
    Exton
    EX3 0PE Exeter
    BritishDesigner61756050005
    GOESS-SAURAU, Johannes
    Schlossberg 1
    Neumarket
    A-838
    Austria
    Amministratore
    Schlossberg 1
    Neumarket
    A-838
    Austria
    AustriaAustrianDirector134737600002
    GOESS-SAURAU, Konrad Johann, Dr
    Temple Farm
    Rockley
    SN8 1RU Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Temple Farm
    Rockley
    SN8 1RU Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomAustrianCompany Director7229970002
    HODGE, Ralph Noel
    Anstye Place
    Anstye
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Anstye Place
    Anstye
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector37679770001
    HOLMES, Shaun David
    36-38 Cornhill
    EC3V 3NG London
    Stephens Europe
    England
    Amministratore
    36-38 Cornhill
    EC3V 3NG London
    Stephens Europe
    England
    EnglandBritishInvestment Banker109823620001
    LEARMOND, Peter Alexander
    Anvil Cottage
    Conford
    GU30 7QW Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    Anvil Cottage
    Conford
    GU30 7QW Liphook
    Hampshire
    BritishCompany Director35551270001
    LEEB, Alexander, Dr
    Gamshof
    Frohn Leiten
    A-8130
    Austria
    Amministratore
    Gamshof
    Frohn Leiten
    A-8130
    Austria
    AustrianConsultant117195010001
    MACULAN, Alexander
    Cranmore Lane
    Shipton Moyne
    GL8 8PU Tetbury
    Lower Cranmore
    England
    Amministratore
    Cranmore Lane
    Shipton Moyne
    GL8 8PU Tetbury
    Lower Cranmore
    England
    EnglandAustrianSelf Employed225413740001
    MEIER, Dieter
    Wohllebgasse 6
    Zurich Ch 8001
    FOREIGN
    Switzerland
    Amministratore
    Wohllebgasse 6
    Zurich Ch 8001
    FOREIGN
    Switzerland
    SwissDirector64083970001
    SMITH, Stephen Michael
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Amministratore
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    EnglandBritishOperations Director240446760001
    TAYLOR, Anthony John
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishDirector98415430002
    WALSH, Mike
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    Amministratore
    Heathfield
    Newton Abbot
    TQ12 6RF Devon
    EnglandBritishNon - Executive Director156674030001
    WEST, Andrew Thomas
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    Amministratore
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinancial Advisor79568920001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Warren Stephens
    Little Rock
    72201
    Arkansas
    111 Center Street
    United States
    06 apr 2016
    Little Rock
    72201
    Arkansas
    111 Center Street
    United States
    No
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BRITISH CERAMIC TILE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 ott 2016
    Consegnato il 25 ott 2016
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as british ceramic tile LTD, old newton road, heathfield, newton abbot TQ12 6RF (title number DN306642).. For further information please refer to the certified copy instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Warren A. Stephens Trust Uid 9/30/87
    Transazioni
    • 25 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2014
    Consegnato il 21 ott 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2013
    Consegnato il 17 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H heathfield newton abbot t/n DN306642. F/h land and buildings on north east side of old newton road heathfield bovey tracey t/n DN412580. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Stephens Investments Holdings Llc
    Transazioni
    • 17 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2013
    Consegnato il 09 ago 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 09 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2012
    Consegnato il 03 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Bank Limited
    Transazioni
    • 03 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 21 mar 2012
    Consegnato il 22 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re british ceramic tile limited and numbered 03097251 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 apr 2008
    Consegnato il 23 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35,520.25 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Rent deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fix-UK General Partner Limited and Fix-UK Nominee Limited
    Transazioni
    • 23 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 2007
    Consegnato il 12 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H heathfield newton abbot devon t/nos DN306642 and DN412580 by way of fixed charge the goodwill and by way of assignment the insurance policy. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 05 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged chattels being all or any part of the furniture fixtures and chattels and other equipment described in the second schedule to the chattels mortgage together with any part or parts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 05 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 2007
    Consegnato il 04 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heathfield newton abbot devon t/nos DN306642 and 412580 and all buildings and fixtures all monies from time to time payable under or pursuant to the insurances and by assignment all rights title and interest in all rents profits income fees adn other sums. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stephens Investments Holdings Llc
    Transazioni
    • 04 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge supplemental to a debenture
    Creato il 11 dic 2003
    Consegnato il 18 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all securities all receivables and all other debts the benefit of all instruments guarantees charges pledges and other security by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Fur Arbeit Und Wirtschaft Aktiengesellschaft (The Bank)
    Transazioni
    • 18 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge over chattels
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 24 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The stocks by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Fur Arbeit Und Wirtschaft Ag
    Transazioni
    • 24 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge over chattels
    Creato il 07 dic 2001
    Consegnato il 17 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    With full title guarantee charged the chattels to the bank by way of first fixed charge and assigned the assigned rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Fur Arbeit Und Wirtschaft Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 17 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge of patents trade marks trade names and goodwill
    Creato il 21 dic 1999
    Consegnato il 10 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    All patents and trade marks goodwill and benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Fur Arbeit Und Wirtschaft Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 10 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 dic 1999
    Consegnato il 29 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1999
    Consegnato il 29 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at heathfield, bovey tracey, teignbridge, devon t/n dn 306642.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 apr 1999
    Consegnato il 28 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether or not the chargee was an original party to the relevant transaction
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all f/h and l/h property including heathfield bovey tracey teignbridge devon t/no DN306642, byway of fixed charge all other land now at the date of the debenture or thereafter becoming the property of the company,all such interest in or over land or inor to the proceeds of sale of land and all licences, fixed charge all chattels attached to any land, chattels being allplant and equipment of the company now or in the future, all chattels as described in part vi of the form M395, all rental and other income and all debts and claims in connection with any lease, agreement or licence relating to land, all contracts therein held now or in the future and policies of insurance and assurance and all rights and interests therein;by way of floating charge all assets being all land and chattels of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Fur Arbeit Und Wirtschaft Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 28 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRITISH CERAMIC TILE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 gen 2019Inizio dell'amministrazione
    29 lug 2022Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Martin Sheridan
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Avon
    Praticante
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Avon
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0