LAUDCARE LIMITED
Panoramica
Nome della società | LAUDCARE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03245110 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LAUDCARE LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova LAUDCARE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street EC2V 7BG London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LAUDCARE LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2018 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2019 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LAUDCARE LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 23 giu 2020 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 04 ago 2020 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 23 giu 2019 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per LAUDCARE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 mar 2024 | 32 pagine | LIQ03 | ||
Dimissioni di un liquidatore | 3 pagine | LIQ06 | ||
Dimissioni di un liquidatore | 3 pagine | LIQ06 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 mar 2023 | 44 pagine | LIQ03 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 25 Moorgate London EC2R 6AY a C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG in data 06 lug 2022 | 2 pagine | AD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB a 25 Moorgate London EC2R 6AY in data 04 apr 2022 | 2 pagine | AD01 | ||
Nomina di un liquidatore volontario | 5 pagine | 600 | ||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 61 pagine | AM22 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB in data 15 nov 2021 | 2 pagine | AD01 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 71 pagine | AM10 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 66 pagine | AM10 | ||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 5 pagine | AM19 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 54 pagine | AM10 | ||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 66 pagine | AM06 | ||
Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA | 16 pagine | AM02 | ||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 67 pagine | AM03 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Norcliffe House Station Road Wilmslow SK9 1BU a C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY in data 24 mar 2020 | 2 pagine | AD01 | ||
Nomina di un amministratore | 5 pagine | AM01 | ||
Cessazione della carica di Martin William Oliver Healy come amministratore in data 30 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Notifica di Mericourt Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||
Nomina di Mr Martin William Oliver Healy come amministratore in data 18 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Richard William Hammond come amministratore in data 18 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione di Elli Finance (Uk) Plc come persona con controllo significativo il 30 apr 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||
Modifica dei dettagli di Elli Finance (Uk) Plc come persona con controllo significativo il 17 mag 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Chi sono gli amministratori di LAUDCARE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTISON, Abigail | Segretario | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188573950001 | |||||||
ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Amministratore | 45 Gresham Street EC2V 7BG London C/O Evelyn Partners Llp | United Kingdom | British | Company Director | 184190020002 | ||||
TABERNER, Benjamin Robert | Amministratore | 45 Gresham Street EC2V 7BG London C/O Evelyn Partners Llp | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 150511890001 | ||||
BAINES, Philip | Segretario | 97 Hangleton Road BN3 7GH Hove East Sussex | British | Director | 3470830001 | |||||
CORMACK, Derek George | Segretario | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | Irish | Finance Dir | 67400530015 | |||||
CROWE, Geoffrey Michael | Segretario | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Director | 38256680007 | |||||
KAY, Dominic Jude | Segretario | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | Solicitor | 145920530001 | |||||
MURPHY, John | Segretario | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Nursing Home Management | 26177180002 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Segretario | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
RM REGISTRARS LIMITED | Segretario nominato | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900000760001 | |||||||
ANSTEAD, Hamilton Douglas | Amministratore | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | Chief Executive | 107751890001 | |||||
BAINES, Philip | Amministratore | 97 Hangleton Road BN3 7GH Hove East Sussex | England | British | Company Secretary | 3470830001 | ||||
BAINES, Philip | Amministratore | 97 Hangleton Road BN3 7GH Hove East Sussex | England | British | Director | 3470830001 | ||||
CALVELEY, Peter, Dr | Amministratore | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | Ceo | 131468590001 | ||||
CHURCHLEY, Peter Knight | Amministratore | Rosevale House Woodside Lane SL4 2DW Windsor Forest Berkshire | England | British | Managing Director | 77173520001 | ||||
CORMACK, Derek George | Amministratore | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | Finance Dir | 67400530015 | ||||
CROWE, Geoffrey Michael | Amministratore | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Director | 38256680007 | |||||
ELLIOTT, Graham Nicholas | Amministratore | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | Company Director | 38064300002 | ||||
HAMMOND, Timothy Richard William | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | England | British | Company Director | 205777760001 | ||||
HEALY, Martin William Oliver | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | Irish | Accountant | 134003120002 | ||||
HEYWOOD, Anthony George | Amministratore | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | Chief Executive | 131288260001 | ||||
HOW, Alistair Maxwell | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 169139000001 | ||||
KAY, Dominic Jude | Amministratore | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 145920530001 | ||||
MAXWELL, Barbara Ann | Amministratore | 17 Crieff Road SW18 2EB London | Irish | Director | 41693200001 | |||||
MITCHELL, Nicholas John | Amministratore | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | Director | 145102120001 | ||||
MURPHY, John | Amministratore | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Nursing Home Management | 26177180002 | |||||
NICHOLSON, Timothy Frantz | Amministratore | 34 Hanover House St Johns Wood High Street NW8 7DX London | American | Managing Director | 43829280001 | |||||
O'REILLY, Michael Patrick | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 40241900001 | ||||
ROBINSON, Anthony Leake | Amministratore | Hamilton House 1 Temple Avenue EC4Y 0HA London | British | Chief Executive | 48323880004 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Amministratore | Garden View 5a Pelling Hill SL4 2LL Old Windsor Berkshire | Irish | Managing Director | 80396000001 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Amministratore | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
SMITH, Ian Richard | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Company Director | 181082310001 | ||||
WILLIS, Graeme | Amministratore | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | Financial Director | 71527500002 | |||||
RM NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900009140001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LAUDCARE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mericourt Limited | 16 lug 2019 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Elli Finance (Uk) Plc | 06 apr 2016 | Suite 3 Regency House 91 Western Road BN1 2NW Brighton C/O Alvarez & Marsal Europe Llp United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Four Seasons Health Care Group Limited | 06 apr 2016 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Four Seasons Health Care Group Limited | 06 apr 2016 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LAUDCARE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A security deed | Creato il 30 ott 2006 Consegnato il 17 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 lug 1999 Consegnato il 04 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee whether present or future, actual or contingent and whether alone, severally, or jointly as principal, guarantor, surety or otherwise and in whatever name or style | |
Brevi particolari First fixed charge l/h oak tree house nursing home yate. First fixed charge on all other f/h, l/h and other immovable property, fixed plant and machinery, goodwill and uncalled capital; first floating charge on the undertaking and property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 28 mag 1999 Consegnato il 03 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at kingsmead nursing/residential home prospect place old town swindon wiltshire (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 28 mag 1999 Consegnato il 03 giu 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at stanshawes nursing home 11 stanshawes drive yate avon (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 28 mag 1999 Consegnato il 03 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at avonmead nursing home canal way devizes (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 28 mag 1999 Consegnato il 03 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at ladymead nursing home wroughton swindon (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 28 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 4TH october 1996 | |
Brevi particolari The initial deposit, all interest, the deposit account and balance relating to the lease of land at blackwell vale nursing home, durdar road, carlisle, cumbria. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 22 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 31ST july 1995 | |
Brevi particolari The tenant charges the initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. Initial deposit means the sum equivalent to twice the basic rent (as the same is defined in the lease) payable in the first full calendar month of the terms (as defined in the said rent deposit deed) following the execution and delivery of the said rent deposit deed.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 22 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 22ND january 1996 | |
Brevi particolari The tenant charges the initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. Initial deposit means the sum equivalent to twice the basic rent (as the same is defined in the lease) payable in the first full calendar month of the term (as defined in the said rent deposit deed) following the execution and delivery of the said rent deposit deed.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 11 apr 1997 Consegnato il 22 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default | |
Brevi particolari The company with full title guarantee charges the initial deposit,all interest,the deposit account being an interest bearing account specifically designated "deposit account" at such bank or institution as the chargee (landlord) shall from time to time decide in it's absolute discretion and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 04 dic 1996 Consegnato il 07 dic 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at stanton lodge nursing home shiremoor newcastle upon tyne and mill brow nursing home mill brow widnes cheshire WA8 6QT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 04 dic 1996 Consegnato il 07 dic 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold premises at blackwell vale nursing home,durdar rd,blackwell,carlisle CA2 4SE and willoughby nursing home,willoughby rd,boston,lincs PE21 9EG; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
LAUDCARE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0