FOCUS HOTELS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FOCUS HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03245987 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FOCUS HOTELS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FOCUS HOTELS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Friars House Quaker Lane PE21 6BZ Boston Lincolnshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FOCUS HOTELS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| REGARDSIGNAL LIMITED | 05 set 1996 | 05 set 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FOCUS HOTELS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per FOCUS HOTELS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 29 mar 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Charity il 15 mag 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Lilian Margaret Charity il 15 mag 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark William Porcher il 30 gen 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FOCUS HOTELS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARITY, Kevin | Segretario | Quaker Lane PE21 6BZ Boston Friars House Lincolnshire England | 160214050001 | |||||||
| CHARITY, Kevin | Amministratore | Quaker Lane PE21 6BZ Boston Friars House Lincolnshire England | England | English | 62498480002 | |||||
| CHARITY, Lilian Margaret | Amministratore | Quaker Lane PE21 6BZ Boston Friars House Lincolnshire England | England | British | 64762040002 | |||||
| PORCHER, Mark William | Amministratore | Quaker Lane PE21 6BZ Boston Friars House Lincolnshire England | England | British | 47748120002 | |||||
| FARRANT, Timothy Robin | Segretario | West Acres Pickering Road West Ayton YO13 9JE Scarborough North Yorkshire | British | 6502170002 | ||||||
| RANDERSON, Michael Ian | Segretario | 25 Northgate Hunmanby YO14 0NT Filey North Yorkshire | British | 34252400002 | ||||||
| WEEDON, Irene | Segretario | The Old School Cottage Barholm PE9 4RA Stamford Lincolnshire | British | 52251710001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| DURRANT, Douglas James | Amministratore | 2 Station View Crossgates YO12 4NG Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 33118170001 | |||||
| FARRANT, Timothy Robin | Amministratore | West Acres Pickering Road West Ayton YO13 9JE Scarborough North Yorkshire | British | 6502170002 | ||||||
| GRIDLEY, Doreen Kay | Amministratore | The Grange 21 Hackness Road YO12 5SD Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 31206470001 | |||||
| LEACH, Kenneth Graham | Amministratore | 17 Lady Ediths Avenue Newby YO12 5RA Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 34252410001 | |||||
| LOCKING, Richard Martin | Amministratore | 4 Bickley Howe YO12 5TR Scarborough North Yorkshire | England | British | 23817640001 | |||||
| MITCHELL, John Brian | Amministratore | 1a The Park Scalby YO13 0PY Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 16958340002 | |||||
| RANDERSON, Michael Ian | Amministratore | 25 Northgate Hunmanby YO14 0NT Filey North Yorkshire | England | British | 34252400002 | |||||
| TAYLOR, Nicholas Richard | Amministratore | Jasmine Cottage 31 Main Street Sewerby Jasmine Cottage Bridlington United Kingdom | United Kingdom | British | 36277750002 | |||||
| WAITE, June Elizabeth | Amministratore | 15 Silver Street Branston LN4 1LR Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 55818590001 | |||||
| WATERHOUSE, George William, Dr | Amministratore | Bridge House Bainton Road Tallington PE9 4RT Stamford Lincolnshire | British | 25162640001 | ||||||
| WEEDON, Brian John | Amministratore | The Old School Cottage Main Street Barholm PE9 4RA Stamford Lincs | British | 2416670001 | ||||||
| WEEDON, Irene | Amministratore | The Old School Cottage Barholm PE9 4RA Stamford Lincolnshire | British | 52251710001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FOCUS HOTELS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coaching Inn Group Ltd | 06 apr 2016 | Quaker Lane PE21 6BZ Boston Friars House Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
FOCUS HOTELS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 18 mag 2011 Consegnato il 06 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies not exceeding £150,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The admiral rodney hotel t/nos LL47941,LL97965,LL98631 and LL280646,fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and all equipment see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 mag 2011 Consegnato il 06 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies not exceeding £150,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The admiral rodney hotel t/nos LL47941,LL97965,LL98631 and LL280646. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 21 ott 1996 Consegnato il 22 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 14 ott 1996 Consegnato il 19 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The admiral rodney hotel north street horncastle lincolnshire benefit of all rights licences contracts deeds undertakings and the assigns of goodwill to the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0