2020 FRANCHISING LTD

2020 FRANCHISING LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società2020 FRANCHISING LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03248728
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 2020 FRANCHISING LTD?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova 2020 FRANCHISING LTD?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 2020 FRANCHISING LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHEM-DRY CHARLIE LIMITED11 set 199611 set 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di 2020 FRANCHISING LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per 2020 FRANCHISING LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Modifica dei dettagli di Independent Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 gen 2023

    2 paginePSC05

    Nomina di Cossey Cosec Services Limited come segretario in data 25 gen 2023

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Rjp Secretaries Limited come segretario in data 25 gen 2023

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Chem-Dry U.K.Limited come persona con controllo significativo il 31 ott 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di Independent Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 31 ott 2022

    2 paginePSC02

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 25 lug 2022

    1 pagineCH02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 18 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Chem-Dry U.K.Limited come persona con controllo significativo il 09 ago 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL in data 12 ago 2019

    1 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Rjp Secretaries Limited il 09 ago 2019

    1 pagineCH04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di 2020 FRANCHISING LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05687325
    149588400001
    MAUGHAN, Anna
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    Segretario
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    British53071850001
    TAYLOR, Mark Andrew
    Springhill 45 Woodland View
    Barnetby Le Wold
    DN38 6FE Brigg
    Lincolnshire
    Segretario
    Springhill 45 Woodland View
    Barnetby Le Wold
    DN38 6FE Brigg
    Lincolnshire
    BritishDirector95264700001
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Segretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British154322040001
    CORPORATE ADMINISTRATION SECRETARIES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    Segretario nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    900006800001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02989995
    61999120002
    BELK, Andrew John
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    Amministratore
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    BritishDirector65603000003
    BELL, Jonathan
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director123082590001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director139480580001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director182208240001
    JOHNSTON, Iain
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomUkAccountant702270001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director207608120001
    LEES, Stuart
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director70032700001
    LLOYD-JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritishDirector149155620001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    BritishBritishAccountant146169560001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Trent Walk
    Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    Amministratore
    Trent Walk
    Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    BritishBritishAccountant146169560001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritishDirector207506140001
    SMITH, Andrew John
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    Amministratore
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    UkBritishDirector149018750001
    TAYLOR, Ian
    4 Parkfield Avenue
    HU14 3AL North Ferriby
    East Yorkshirede
    Amministratore
    4 Parkfield Avenue
    HU14 3AL North Ferriby
    East Yorkshirede
    EnglandBritishDirector6673550003
    TAYLOR, Mark Andrew
    Westlands
    Queensgate
    HU17 8NE Beverley
    Amministratore
    Westlands
    Queensgate
    HU17 8NE Beverley
    United KingdomBritishDirector95264700003
    TAYLOR, Mark Andrew
    Springhill 45 Woodland View
    Barnetby Le Wold
    DN38 6FE Brigg
    Lincolnshire
    Amministratore
    Springhill 45 Woodland View
    Barnetby Le Wold
    DN38 6FE Brigg
    Lincolnshire
    BritishSecretary95264700001
    CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    Amministratore delegato nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    900006790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di 2020 FRANCHISING LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    31 ott 2022
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06732498
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Gold Round Limited
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Chem-Dry U.K.Limited
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione02788087
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    2020 FRANCHISING LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 set 2016
    Consegnato il 13 set 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Blackstar 2016 Limited
    Transazioni
    • 13 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 2016
    Consegnato il 16 giu 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 08 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transazioni
    • 08 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 08 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2010
    Consegnato il 07 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Evander Limited
    Transazioni
    • 07 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 10 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 05 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 set 2009
    Consegnato il 14 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jonathan Simpson-Dent (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 14 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 24 set 2009
    Consegnato il 02 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 set 2009
    Consegnato il 03 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 05 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property 22 park street hull. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2000
    Consegnato il 15 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0