MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03249066 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
- Attività di società di venture capital e di sviluppo (64303) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ENTERPRISE VENTURES LIMITED | 26 giu 1997 | 26 giu 1997 |
| ENTERPRISE REGIONAL VENTURES LIMITED | 05 nov 1996 | 05 nov 1996 |
| INHOCO 550 LIMITED | 12 set 1996 | 12 set 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 12 set 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 26 set 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 12 set 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 mar 2025 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2024 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2023 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed enterprise ventures LIMITED\certificate issued on 22/11/23 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Michael Dines come amministratore in data 15 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Wayne Leslie Thomas come amministratore in data 12 gen 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2022 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Sarah-Louise Anne Thawley il 31 mag 2022 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Simpson come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2021 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Wayne Leslie Thomas come amministratore in data 10 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr William Arthur Clark come amministratore in data 10 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Miss Sarah-Louise Anne Thawley come segretario in data 01 lug 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Simpson come segretario in data 01 lug 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Michael Dines come amministratore in data 14 ago 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Sarah-Louise Anne | Segretario | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | 271848800002 | |||||||
| CLARK, William Arthur | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 147210190001 | |||||
| GLANFIELD, Martin James | Amministratore | 17 High Street B95 5AA Henley-In-Arden Forward House West Midlands England | United Kingdom | British | 206032560001 | |||||
| PAYTON, Mark Andrew | Amministratore | High Street B95 5AA Henley-In-Arden Forward House West Midlands England | England | British | 108730330001 | |||||
| VIGGARS, Julian George | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 122088920001 | |||||
| BAMFORD, Richard William | Segretario | 12 Royal Avenue Fulwood PR2 9XP Preston | British | 2091120002 | ||||||
| DIGGINES, Jonathan Brett | Segretario | The Garth 27 Planetree Road Hale WA15 9JN Altrincham Cheshire | British | 80119110004 | ||||||
| GAVAN, John Vincent | Segretario | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | British | 36153790001 | ||||||
| HEPPER, Richard John | Segretario | Gunton Barn The Green, Charney Bassett OX12 0EU Wantage Oxfordshire | British | 123224920001 | ||||||
| SIMPSON, Andrew John | Segretario | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | British | 35413320002 | ||||||
| WILLIAMS, Neil Edward | Segretario | 57 Albany Drive Walton Le Dale PR5 4TX Preston Lancashire | British | 2927950001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| BAMFORD, Richard William | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | England | British | 2091120002 | |||||
| BAMFORD, Richard William | Amministratore | 12 Royal Avenue Fulwood PR2 9XP Preston | England | British | 2091120002 | |||||
| CAUNCE, Henry | Amministratore | 324a Preston Old Road BB2 2TX Blackburn Lancashire | British | 35445360001 | ||||||
| CAUNCE, Henry | Amministratore | 324a Preston Old Road BB2 2TX Blackburn Lancashire | British | 35445360001 | ||||||
| DIGGINES, Jonathan Brett | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 80119110004 | |||||
| DINES, Peter Michael | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | England | British | 103467350002 | |||||
| ELLMAN, Louise Joyce | Amministratore | 40 Elmers Green WN8 6SB Skelmersdale Lancashire | British | 3275570001 | ||||||
| FURLONG, Gwynne Patrick | Amministratore | Triggs Farm Fishwick Lane Higher Wheelton PR6 8HT Chorley Lancs | England | British | 14172020001 | |||||
| GAVAN, John Vincent | Amministratore | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | England | British | 36153790001 | |||||
| HALL, David Ian | Amministratore | 37 Buckingham Avenue Whitefield M45 6DJ Manchester Lancashire | British | 8767460001 | ||||||
| HEPPER, Richard John | Amministratore | Gunton Barn The Green, Charney Bassett OX12 0EU Wantage Oxfordshire | British | 123224920001 | ||||||
| HOYLE, John Roger Horrocks | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | England | British | 3986300002 | |||||
| HYNES, Michael Robert | Amministratore | 13 Chapman Road Fulwood PR2 8NX Preston Lancashire | United Kingdom | British | 2927960001 | |||||
| HYNES, Michael Robert | Amministratore | 13 Chapman Road Fulwood PR2 8NX Preston Lancashire | United Kingdom | British | 2927960001 | |||||
| KING, Laurence | Amministratore | Conifers 6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston Lancashire | England | British | 51624810001 | |||||
| LANDAU, Dennis Marcus, Sir | Amministratore | Thorncroft Pedley Hill Rainow SK10 5TZ Macclesfield Cheshire | British | 12187600002 | ||||||
| MASON, James | Amministratore | Rock Mount 61 The Row Silverdale LA5 0UG Carnforth Lancashire | British | 56622430001 | ||||||
| MCINNES, Randolf Graham | Amministratore | Journeys End Werneth Low SK14 3AF Stockport Cheshire | England | British | 100684180001 | |||||
| MEAD, Matthew Sidney | Amministratore | 17 High Street B95 5AA Henley-In-Arden Forward House West Midlands England | United Kingdom | British | 206032800001 | |||||
| NOON, Francis | Amministratore | Rosehill Chapel Fold, Wiswell BB7 9DE Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | 80894430001 | |||||
| PATEL, Adam Hafajee | Amministratore | Snodworth Hall Snodworth Road Langho BB6 8DS Blackburn Lancashire | British | 12489070001 | ||||||
| RAWLINSON, Stephen Joseph | Amministratore | 44 St Marys Road Long Ditton KT6 5EY Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 126778230001 | |||||
| ROSS, Stephen John | Amministratore | Preston Technology Management Centre Marsh Lane PR1 8UQ Preston Lancashire | England | British | 140329400001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MERCIA REGIONAL VENTURES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Ventures Group Limited | 06 apr 2016 | Preston Technology Centre, Marsh Lane PR1 8UQ Preston Ptmc Lancashire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0