ALPHABET LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALPHABET LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03250737
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALPHABET LIMITED?

    • (5540) /

    Dove si trova ALPHABET LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hillcroft
    Dartford Road
    DA4 9HX Horton Kirby
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALPHABET LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE DOZY DUCK LTD.17 set 199617 set 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALPHABET LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ALPHABET LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2008

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2007

    3 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2006

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2005

    5 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2004

    5 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mag 2003

    6 pagineAA

    legacy

    9 pagine363s

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di ALPHABET LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCKINNON CLARK, Nigel
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    Segretario
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    British82806600001
    DRAPER, Mark James
    120 Station Road
    TW12 2AP Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    120 Station Road
    TW12 2AP Hampton
    Middlesex
    British82806640003
    MCKINNON CLARK, Nigel
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82806600001
    BIERER, Gideon Itamar David Jodeph
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    Segretario
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    British60921420001
    CARNE, Charles Nicholas
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    Segretario
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    British30651520002
    HOAD, Francis Alister Knox
    93a Albert Street
    NW1 7LX London
    Segretario
    93a Albert Street
    NW1 7LX London
    Australian51041550001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BARROW, Paul Achilles St Clair
    9 Hollywood Mews
    Chelsea
    SW10 9HU London
    Amministratore
    9 Hollywood Mews
    Chelsea
    SW10 9HU London
    United KingdomBritish51162560001
    BIERER, Gideon Itamar David Jodeph
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    Amministratore
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    British60921420001
    BOULTON, Matthew Gresford
    19 Allestree Road
    SW6 6AD London
    Amministratore
    19 Allestree Road
    SW6 6AD London
    British48810030002
    CARNE, Charles Nicholas
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    Amministratore
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    United KingdomBritish30651520002
    COURT, Philippe
    Flat 6
    36-42 Clerkenwell Road, Clerkenwell
    EC1M 5PS London
    Amministratore
    Flat 6
    36-42 Clerkenwell Road, Clerkenwell
    EC1M 5PS London
    British108361790001
    MAILLARD, Andrew Clement
    10a Mozart Street
    W10 4LA London
    Amministratore
    10a Mozart Street
    W10 4LA London
    British58698360001
    SURL, Mark Edwin
    286 Upland Road
    SE22 0DP London
    Amministratore
    286 Upland Road
    SE22 0DP London
    British64367620002
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Amministratore delegato nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001

    ALPHABET LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2006
    Consegnato il 19 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or alphabet bars limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H amber bar 6 poland street london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2006
    Consegnato il 19 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or alphabet bars limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H alphabet bar 61-63 beak street london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 23 mag 2006
    Consegnato il 26 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 ott 2003
    Consegnato il 07 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 07 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ott 2000
    Consegnato il 18 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as 6 poland st,london; NGL789728. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 ott 2000
    Consegnato il 17 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 ott 2000
    Consegnato il 17 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as 61-63 beak st,london. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 ago 2000
    Consegnato il 19 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    £42,300.00 due from the company to the chargee under the lease of even date
    Brevi particolari
    £42,300 pursuant to this deed.
    Persone aventi diritto
    • Mddt Nominees S.A.and Wilfe Nominees Limited
    Transazioni
    • 19 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 gen 1997
    Consegnato il 08 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £32,312.50 and all other sums due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Rent deposit in the sum of £32,312.50.
    Persone aventi diritto
    • Capitalstart Limited
    Transazioni
    • 08 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0