NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED

NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03252047
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o WILDER COE LLP
    Oxford House Campus 6
    Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHARGEZOOM LIMITED19 set 199619 set 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2014

    11 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 set 2013

    10 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 01 ott 2012

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Croft Chambers 11 Bancroft Hitchin Herts SG5 1JQ* in data 27 set 2012

    2 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ott 2011 al 30 apr 2012

    3 pagineAA01

    Nomina di Bradshaw Johnson Secretarial Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da * Enteract Limited 509 Broadway Letchworth Hertfordshire SG6 3PT* in data 17 lug 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Kevin Pearson come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Robert Walker come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Miles Shelley come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Mcalpine come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Eaton Court Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7TR* in data 23 apr 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 set 2011

    Stato del capitale al 29 set 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Alexander Hooton come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADSHAW JOHNSON SECRETARIAL LIMITED
    Bancroft
    SG5 1JQ Hitchin
    Croft Chambers 11
    Herts
    Segretario
    Bancroft
    SG5 1JQ Hitchin
    Croft Chambers 11
    Herts
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4620404
    88373140002
    JOHNSON, Garry
    509 Broadway
    SG6 3PT Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    509 Broadway
    SG6 3PT Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinancial Consultant7628830001
    COWEN, Brendon Raymond
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    British1234020001
    PEARSON, Kevin John
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Segretario
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    British106469170001
    WALKER, Robert Peter
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Segretario
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    British11492400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    HOOTON, Alexander Dermot Leslie Sydney
    1 Langley Wood
    Barnfield Wood Road
    BR3 6SS Beckenham
    Kent
    Amministratore
    1 Langley Wood
    Barnfield Wood Road
    BR3 6SS Beckenham
    Kent
    BritishTax & Development Consultant52626850004
    MCALPINE, Andrew William, Sir
    Tyne House
    23 Side
    NE1 3JL Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Tyne House
    23 Side
    NE1 3JL Newcastle Upon Tyne
    BritishCivil Engineering & Building C92904640002
    SHELLEY, Miles Colin
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant44005940002
    WALKER TAYLOR, Patrick Hugh
    15 Upper Hill Rise
    WD3 7NU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Upper Hill Rise
    WD3 7NU Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishGroup Financial Director111015350001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Payment account charge
    Creato il 02 apr 1999
    Consegnato il 22 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the developer's leases and of the prelet lease and clauses 8.10(b) and 8.3.2(b) of the development agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All secured obligations and the full credit balance therein and all rights/benefits arising therewith; see form 395. undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Robert John Hugo Randall and David John George Royds,as Trustees of the Royal Quays No 1SYNDICATE Trust
    Transazioni
    • 22 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Construction account charge
    Creato il 02 apr 1999
    Consegnato il 22 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the building contract in respect of the base building works and to carry out and complete the development (other than the fit out works) and to remedy any defects therein in accordance with clauses 3 and 6 of the development agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All secured obligations and the account/full credit balance thereon and all rights/benefits accruing therewith; see form 395. undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • David John George Royds and Robert John Hugo Randall,the Trustees of the Royal Quays No 1SYNDICATE Trust
    Transazioni
    • 22 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment of bank deposit and right to receive liquidated damages
    Creato il 02 apr 1999
    Consegnato il 22 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clauses 15.5 and 15.6 of the agreement including the obligations of the company to establish the security account and to assign it to the chargee
    Brevi particolari
    All monies and performance of all obligations and the damages and all right,title,benefit and interest whatsoever; the certificates of deposit,receipts or other instruments or securities thereon; see form 395. undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Robert John Hugo Randall and David John George Royds,as Trustees of the Royal Quays No 1SYNDICATE Trust
    Transazioni
    • 22 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Construction cost charge
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 22 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    The obligations of the company to the chargee under clause 24 of a purchase and development agreement dated 5 march 1997 to guarantee the obligations of european microelectronics institute under clause 5 and clause 6.3.2(a) of the said purchase and development agreement and the company's obligation to pay all and any costs and other amounts arising as a result of any breach termination or frustration thereof
    Brevi particolari
    The sums belonging to the company from time to time standing to the credit of an account k/a laser xi construction security account with the bank of scotland at 38 st andrew square,edinburgh EH2 2YR scotland,the initial amount being £8,538,903.
    Persone aventi diritto
    • Sun Alliance Trust Company Limited
    Transazioni
    • 22 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Construction security deed
    Creato il 10 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities due or to become from the company to the chargee pursuant to the terms of a development agreement dated 29/11/96
    Brevi particolari
    All rights to and interest in an acount held with barclays bank PLC in the name of northernmicro developments limited and k/a the howden road -emi construction security account.
    Persone aventi diritto
    • European Microelectronics Institute
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 feb 1997
    Consegnato il 21 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and european microelectronics institute (the borrower) to the chargee pursuant to the loan agreement
    Brevi particolari
    All sums from time to time standing to the credit of the security account (as defined in the loan agreement) and all sums from time to time standing to the credit of the interest accumulation account (as defined) together with all rights relating or attaching thereto all that leasehold land and buildings known as plot 4 and plot 5 howdon road north shields newcastle upon tyne t/no TY326944 all right title interest and benefit in each of the transaction documents and by way of floating charge all the property assets including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NORTHERNMICRO DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2012Inizio della liquidazione
    20 feb 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Brian Dix
    Wilder Coe Llp Oxford House Campus Six
    Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts
    Praticante
    Wilder Coe Llp Oxford House Campus Six
    Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts
    Norman Cowan
    Oxford House Campus Six
    Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts
    Praticante
    Oxford House Campus Six
    Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts
    Panos Papas
    Oxford House, Campus 6 Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts
    Praticante
    Oxford House, Campus 6 Caxton Way
    SG1 2XD Stevenage
    Herts

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0