SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED

SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03255699
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    K House Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAFM INVESTMENTS LIMITED18 dic 199618 dic 1996
    INGLEBY (943) LIMITED27 set 199627 set 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 nov 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c and capital redemption reserve 24/11/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ago 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da St Crispins Duke Street Norwich Norfolk NR3 1PD a K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU in data 12 mag 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Lorna Kathleen Mendelsohn come segretario in data 28 apr 2016

    2 pagineAP03

    Soddisfazione dell'onere 032556990014 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032556990015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032556990016 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032556990011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032556990013 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032556990012 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Robert Rolph Baldrey come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Haworth come amministratore in data 13 apr 2016

    2 pagineAP01

    legacy

    50 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Bilancio annuale redatto al 03 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2015

    Stato del capitale al 28 ago 2015

    • Capitale: GBP 244,707
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    20 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MENDELSOHN, Lorna Kathleen
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Segretario
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    208083460001
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155681500001
    HAWORTH, Stephen
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155690570001
    ANGRAVE, Leon Francis
    7 Hunters Walk
    Witherley
    CV9 3SU Atherstone
    Warwickshire
    Segretario
    7 Hunters Walk
    Witherley
    CV9 3SU Atherstone
    Warwickshire
    British1558740001
    CALDWELL, David
    123 Lutterworth Road
    CV11 6QA Nuneaton
    Warwickshire
    Segretario
    123 Lutterworth Road
    CV11 6QA Nuneaton
    Warwickshire
    United Kingdom1050470002
    FOWEN, Yvonne Pauline
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Segretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British26389070002
    HOLMES, Julian
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    Segretario
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    British110668840001
    SMITH, Angela Clare
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    Segretario
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    British100635720001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Segretario nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    ANGRAVE, Leon Francis
    Lower Ambion House
    Ambion Lane, Sutton Cheney
    CV13 0AD Nuneaton
    Amministratore
    Lower Ambion House
    Ambion Lane, Sutton Cheney
    CV13 0AD Nuneaton
    British1558740002
    AVERY, Stephen Thomas
    Riverside House
    The Orchards Roecliffe
    WF4 2LB Boroughbridge
    North Yorkshire
    Amministratore
    Riverside House
    The Orchards Roecliffe
    WF4 2LB Boroughbridge
    North Yorkshire
    United KingdomBritish52690520004
    BALDREY, Robert Rolph
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish78328360005
    BRETTELL, Timothy Geoffrey
    Abbots Leigh House
    Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Amministratore
    Abbots Leigh House
    Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    British16193990002
    CALDWELL, David
    123 Lutterworth Road
    CV11 6QA Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    123 Lutterworth Road
    CV11 6QA Nuneaton
    Warwickshire
    EnglandUnited Kingdom1050470002
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    United KingdomBritish41820960003
    CROMACK, Jason Charles Edward
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish148492510001
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish130923460003
    HODGSON, Richard
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    Amministratore
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    United KingdomBritish96788660005
    HOOLE, Peter David
    The Small House
    High St Sherington
    MK16 9NB Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Small House
    High St Sherington
    MK16 9NB Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13747930001
    HOUSTON, Peter Richard Vivian
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    Amministratore
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    United KingdomBritish113014870001
    MCGOLDRICK, Fergus Charles
    3 The Drive
    NN15 7EX Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 The Drive
    NN15 7EX Kettering
    Northamptonshire
    British50859140003
    MOATE, Simon Richard
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish126182400002
    WONG, Jun Tsiong
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    Amministratore
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    British72387070003
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Endless Ii Gp Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    Endinburgh
    50
    Scotland
    06 apr 2016
    Lothian Road
    Festival Square
    Endinburgh
    50
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc335665
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Access Plus Limited
    Sheffield Airport Business Park, Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    06 apr 2016
    Sheffield Airport Business Park, Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02600683
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Endless Iii General Partner Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    Edinburgh
    50
    Scotland
    06 apr 2016
    Lothian Road
    Festival Square
    Edinburgh
    50
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc303405
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Endless Llp
    Whitehall Quay
    LS1 4BF Leeds
    3
    England
    06 apr 2016
    Whitehall Quay
    LS1 4BF Leeds
    3
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneOc316569
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    SOFTWARE STATIONERY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property K.a 16A crawfordsburn road newtownards county down.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 30 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 29 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 29 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of accession in respect of a debenture dated 23 october 2003
    Creato il 26 feb 2004
    Consegnato il 10 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property units 2 and 3 northern perimeter road west hinckley leicestershire t/n LT244150. L/h property unit 1 gildersome spur distribution centre wakefield road leeds. L/h property access house clifton down bristol (part lower ground, first and second floors).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Working capital composite guarantee and debenture
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 13 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold property known as units 2 and 3 northern perimeter road west hinckley leicestershire t/n LT244150 the leasehold property known as unit 1 gildersome spur distribution centre wakefield road leeds and the leasehold property known as access house clifton down bristol (part lower ground, ground, first and second floors). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 set 2000
    Consegnato il 09 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 1997
    Consegnato il 06 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0