PH PROPERTY COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PH PROPERTY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03255711 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| QUALITY CARE PROPERTY LIMITED | 25 ott 1996 | 25 ott 1996 |
| CARRYHIGH LIMITED | 27 set 1996 | 27 set 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 ott 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Richard Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PH PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTISON, Abigail | Segretario | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188574890001 | |||||||
| ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Amministratore | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | 184190020002 | |||||
| SMITH, Ian Richard | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||
| TABERNER, Benjamin Robert | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 150511890001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Segretario | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| DARK, Anthony Hedley | Segretario | 57 Crescent Lane SW4 9PT Clapham London | British | 84286690001 | ||||||
| GOSLING, Mark David | Segretario | 8 Dane Close Hartlip ME9 7TN Sittingbourne Kent | British | 66801660001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Segretario | 33 Cheyne Place SW3 4HL London | Singaporean | 37858790001 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Segretario | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||
| NUNN, Andrew James | Segretario | 1 Edward Street Gosforth NE3 1EA Newcastle Upon Tyne | British | 54511610001 | ||||||
| PARK, Sonya C | Segretario | 138 Dalston Lane E8 1NG London | American | 75811580001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Segretario nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| ANSTEAD, Hamilton Douglas | Amministratore | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | 107751890001 | ||||||
| BAILEY JR, Essel William | Amministratore | 1 Hillside Court Ann Arbor Mi 48104 Usa | American | 82601840001 | ||||||
| BANNATYNE, Duncan Walker | Amministratore | 55 Cleveland Avenue DL3 7HF Darlington County Durham | British | 53468760002 | ||||||
| CALVELEY, Peter, Dr | Amministratore | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | 131468590001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Amministratore | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| DAVISON, Andrew John | Amministratore | Well House Cambo NE61 4BP Morpeth Northumberland | British | 3159270005 | ||||||
| ELLIOTT, Graham Nicholas | Amministratore | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | 38064300002 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | 28 Harley House Marylebone Road NW1 5HF London | American | 52843400002 | ||||||
| FRANKE, Thomas Frederick | Amministratore | 410 North Eagle Street 49068 Marshall Michigan Usa | United Kingdom | American | 50747000001 | |||||
| GOTTESMAN, Arthur Edward | Amministratore | 38 Chester Terrace Regents Park NW1 4ND London | American | 35293490001 | ||||||
| HEYWOOD, Anthony George | Amministratore | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| KAY, Dominic Jude | Amministratore | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | 145920530001 | |||||
| MAXWELL, Barbara Ann | Amministratore | 17 Crieff Road SW18 2EB London | Irish | 41693200001 | ||||||
| MITCHELL, Nicholas John | Amministratore | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 145102120001 | |||||
| RUTTER, Christopher | Amministratore | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| WILLIS, Graeme | Amministratore | 4 Woodbank Lynton Lane SK9 7NP Alderley Edge Cheshire | British | 71527500004 | ||||||
| WILLIS, Graeme | Amministratore | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | 71527500002 | ||||||
| JL NOMINEES ONE LIMITED | Amministratore delegato nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
PH PROPERTY COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security accession deed | Creato il 06 set 2002 Consegnato il 14 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 nov 1996 Consegnato il 25 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage (customer's account) | Creato il 31 ott 1996 Consegnato il 09 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (I) eastbourne nursing home,7 cobden st,darlington; t/no du 123525; (ii) burlam road nursing home,111 and 113 burlam rd,middlesbrough; tes 20264; (iii) the laurels and regents view nursing home,francis way,houghton le spring; ty 273629 and 23 other listed properties; the proceeds of sale thereof and goodwill of business; all guarantees,insurance or other monies and all rights; all fixed fixtures,fittings,plant and machinery thereon; see form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0