MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03259295
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    • Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL (CIS) LIMITED24 dic 199624 dic 1996
    ENGAGEBEAM LIMITED04 ott 199604 ott 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo

    2 paginePSC05

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mag 2017

    • Capitale: GBP 2,845,447.00
    8 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    31 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Restriction on auth share cap is revoked and deleted 31/05/2017
    RES13

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Johannes Jacobus Olivier il 01 dic 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mag 2016

    13 pagineAA

    legacy

    60 paginePARENT_ACC

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Nomina di Thomas Edward Kilroy come amministratore in data 21 mar 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mag 2015

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    60 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2015

    Stato del capitale al 02 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Johannes Jacobus Olivier come amministratore in data 20 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Paul Woodward come amministratore in data 20 lug 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2014

    Stato del capitale al 10 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Andrew Paul Woodward come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sanjay Patel come amministratore in data 28 ago 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    KILROY, Thomas Edward
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    EnglandBritish166580200001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandSouth African199516920002
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    Segretario
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    146638030001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Segretario
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    170449330001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DARBY, Andrew Hamish
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish114800800001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    Amministratore
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Amministratore
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITE, Andrew Ian
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    Amministratore
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    United KingdomBritish93602410001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Amministratore
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002

    Chi sono le persone con controllo significativo di MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1752099
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0