QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03260375
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HUDSON HOMES LIMITED08 ott 199608 ott 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 11 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2015

    Stato del capitale al 01 ott 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 20 lug 2015

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 05 ago 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Jonathan David Farkas come amministratore in data 27 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mathieu Streiff come amministratore in data 27 gen 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    28 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 11 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 set 2014

    Stato del capitale al 18 set 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mathieu Streiff il 31 mar 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 31 mar 2014

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da * Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom* in data 07 apr 2014

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2014 al 31 dic 2013

    3 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ott 2013

    Stato del capitale al 07 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Segretario
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmerican193539990001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    British155548170001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Segretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    CO FORM (SECRETARIES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Segretario nominato
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001870001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish119804090001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish155548170001
    SAUNDERS, Peter Michael, Cllr
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish65642810001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    Amministratore
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United StatesAmerican200529310001
    TRANTER, Wilfred
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    Amministratore
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    British18193010002
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish133383410003
    CO FORM (NOMINEES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    06 apr 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04258255
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 nov 2007
    Consegnato il 27 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H miranda house high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT139689. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the old presbytery high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT131191. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 03 nov 1999
    Consegnato il 24 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as the old presbytery 77 high street, wootton bassett wilts title number WT131191. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1997
    Consegnato il 19 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a miranda house nursing home high street wootton bassett t/no: WT139689.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 apr 1997
    Consegnato il 19 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0