CAMCO CORPORATION LIMITED

CAMCO CORPORATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAMCO CORPORATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03260511
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAMCO CORPORATION LIMITED?

    • (7414) /
    • (7487) /

    Dove si trova CAMCO CORPORATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regent House 316 Beulah Hill
    Upper Norwood
    SE19 3HF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAMCO CORPORATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAMCO TRADING LIMITED26 set 199726 set 1997
    CAMCO CORPORATION LIMITED10 feb 199710 feb 1997
    TAIPAN VENTURES LIMITED29 ott 199629 ott 1996
    COMBRAY LIMITED08 ott 199608 ott 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAMCO CORPORATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CAMCO CORPORATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ott 2009

    Stato del capitale al 12 ott 2009

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed camco trading LIMITED\certificate issued on 08/02/05
    2 pagineCERTNM

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CAMCO CORPORATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OXFORD CORPORATE SERVICES LTD
    12 Payton Street
    CV37 6UA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    12 Payton Street
    CV37 6UA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    66596380001
    BAYNHAM, Roger James
    Bakers Barn
    Bournes Green
    GL6 7NW Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bakers Barn
    Bournes Green
    GL6 7NW Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director49579990002
    BROOKS, Kenneth Williams
    Glebe House Church End
    South Leigh
    OX8 6UR Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    Glebe House Church End
    South Leigh
    OX8 6UR Witney
    Oxfordshire
    United KingdomBritishSolicitor5372650001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    BALDRY, Anthony Brian, Sir
    Church Street
    Bloxham
    OX15 4ET Nr Banbury
    Dovecote House
    Oxfordshire
    Amministratore
    Church Street
    Bloxham
    OX15 4ET Nr Banbury
    Dovecote House
    Oxfordshire
    United KingdomBritishBarrister135568740001
    CLARK, Dennis John Carney
    52 Chesterton House
    Ingrave Street
    SW11 2UD London
    Amministratore
    52 Chesterton House
    Ingrave Street
    SW11 2UD London
    BritishCeo68109000001
    DALEY, Sean
    31 Hunt Close
    The Grange
    OX26 6HX Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    31 Hunt Close
    The Grange
    OX26 6HX Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritishTextiles86272010001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Amministratore delegato nominato
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    MACKAY, Niall John
    The Old Milking Parlour
    Downley Farms Barns, Plomer Green Lane Downley
    HP13 5XN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Milking Parlour
    Downley Farms Barns, Plomer Green Lane Downley
    HP13 5XN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director109954310001
    QUINN JNR, William James
    14497 Edmore
    48205 Detriot
    Michigan
    Usa
    Amministratore
    14497 Edmore
    48205 Detriot
    Michigan
    Usa
    AmericanStockbroker50954080001
    WIDGER, William Frank
    130 Lake Shore Drive North
    Palm Harbor
    Florida 34684
    United States Of America
    Amministratore
    130 Lake Shore Drive North
    Palm Harbor
    Florida 34684
    United States Of America
    AmericanCompany Director50954110001

    CAMCO CORPORATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 giu 1998
    Consegnato il 03 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 26TH june 1998
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sibbabridge Services PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0