MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED

MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMERRYCHEF HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03274972
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLAKEDEW TWENTY FOUR LIMITED07 nov 199607 nov 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 nov 2012

    Stato del capitale al 08 nov 2012

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Graham Philip Brisley Veal il 30 set 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Maurice Delon Jones il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael James Kachmer il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Graham Philip Brisley Veal il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Segretario
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Segretario nominato
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001990001
    AIREY, Andrew Robert
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    British70927410002
    BARKER, Simon Charles
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    British113730600001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BRAY, Kenneth Ivor
    Nether Hall
    Main Street, Denton
    NG32 1JR Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Nether Hall
    Main Street, Denton
    NG32 1JR Grantham
    Lincolnshire
    British45153770002
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GALE, Robert Geoffrey
    Hurlands Lane
    GU8 4NT Dunsfold
    Hurst Hill Lodge
    Surrey
    Uk
    Amministratore
    Hurlands Lane
    GU8 4NT Dunsfold
    Hurst Hill Lodge
    Surrey
    Uk
    United KingdomBritish138375430001
    HAMPTON, Mark Richard
    Bankside 5 Parsonage Road
    HP8 4JW Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bankside 5 Parsonage Road
    HP8 4JW Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    British80408810001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    HOUGHTON, Reece
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    British27953100001
    JELLY, Aubrey Bruce, Mr.
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    Amministratore
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    United KingdomBritish82764370003
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    LEE, Peter Allan
    4 Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    Berkshire
    Amministratore
    4 Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    Berkshire
    British81538800001
    MILLER, Stuart Purves
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish98718070001
    ROLT, Jeremy Charles
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish35716980001
    THORNEYWORK, Nigel
    Malden Dale Bailes Lane
    Normandy
    GU3 2AX Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Malden Dale Bailes Lane
    Normandy
    GU3 2AX Guildford
    Surrey
    EnglandBritish9730100001
    TONER, Robert Anthony
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish70516300002
    WHITELING, Mark Argent
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish101297630001
    WOODHEAD, Graham Geoffrey
    Hammer Cottage
    RH5 6QX Abinger Hammer
    Surrey
    Amministratore
    Hammer Cottage
    RH5 6QX Abinger Hammer
    Surrey
    United KingdomBritish2703560002
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore delegato nominato
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001980001

    MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 28 lug 1997
    Consegnato il 05 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness,liabilities and obligations due or to become due by any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The assignor assigned and agreed to assign with full title guarantee to the bank the policies and all monies including bonuses accrued or which may at any time after 28 july 1997 accrue which shall become payable thereunder and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same absolutely as a continuing security to the bank.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 27 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises at station road west,ashvale,aldershot,hampshire GU12 5XA; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0