CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED

CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCUMBRIAN HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03275686
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CUMBRIAN SEAFOODS LIMITED17 feb 199717 feb 1997
    HOODCO 531 LIMITED08 nov 199608 nov 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 mar 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Progress report ends 13/01/2016
    13 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Progress Report
    15 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:liquidators progress report
    9 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:progress report
    12 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 set 2012

    16 pagine2.24B

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    19 pagine2.33B

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 giu 2012

    23 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    1 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    40 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    24 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    17 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Foxcover 7 Admiralty Way Foxcover Industrial Estate Seaham County Durham SR7 7DN* in data 05 gen 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 08 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 nov 2011

    Stato del capitale al 11 nov 2011

    • Capitale: GBP 846,233
    SH01

    Cessazione della carica di Michael Vassallo come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    7 pagineMG01

    Cessazione della carica di Howard Sims come amministratore

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VASSALLO, Peter
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    Segretario
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    BritishCompany Director49018830002
    GILTHORPE, David Alexander
    Lady Park Farm Cottage Lady Park
    NE11 0HD Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Lady Park Farm Cottage Lady Park
    NE11 0HD Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishChartered Accountant42515160001
    VASSALLO, Peter
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    Amministratore
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director49018830002
    ALLAN, Peter Riddle
    5 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    5 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishSolicitor35573440001
    ROGAN, Eileen Theresa
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    Segretario nominato
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British900013580001
    FLYNN, Austin
    201 Sandyford Road
    NE2 1NP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    201 Sandyford Road
    NE2 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900009310001
    FORSYTH, Martin Peter
    Broomlands
    High Lorton
    CA13 9UL Cockermouth
    Cumbria
    Amministratore
    Broomlands
    High Lorton
    CA13 9UL Cockermouth
    Cumbria
    BritishCompany Director56015200003
    PORTERGILL, Richard George
    Abbey View
    Henley Road
    SL7 2DQ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Abbey View
    Henley Road
    SL7 2DQ Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director2563880005
    RHODES, David Mitchell
    Greenacres
    Ullock
    CA14 4TP Cockermouth
    Cumbria
    Amministratore
    Greenacres
    Ullock
    CA14 4TP Cockermouth
    Cumbria
    BritishCompany Director75199880001
    ROGAN, Eileen Theresa
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore delegato nominato
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British900013580001
    SIMS, Howard
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    Amministratore
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director156051970001
    VASSALLO, Michael
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    Amministratore
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    EnglandBritishChartered Accountant156050660001

    CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 19 ott 2011
    Consegnato il 24 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Right title and interest in and to the property specified in the schedule of the supplemental deed, being more particularly: 1 ordinary share of £1.00 in cumbrian seafoods limited, 1 ordinary share of £1.00 in cumbrian shellco limited and 100 ordinary shares of £1.00 each in border laird limited see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge over shares
    Creato il 19 ago 2009
    Consegnato il 26 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charged securities, means the 100,000 new ordinary shares of grants smokehouse limited all related rights, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Aircraft mortgage
    Creato il 30 nov 1999
    Consegnato il 11 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £581,000 together with all sums due or to become due from the company and cumbrian seafoods inc to the charge under the terms of the transaction documents by way of principal or interest
    Brevi particolari
    Md helicopters 600 notar helicopter s/n RN048 reg mark n-600PV the insurance and the requisition compensation.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 24 ago 1999
    Consegnato il 03 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 03 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 08 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Equipment such ASB9 fiigoscandia frying line, deglazer, predust s/n 8010-14-1143, batter applicator s/n 10-14-1143, breader s/n 010-14-1143, conveyor s/n DF301G25PD, fryer (model tff-2415) s/m 273, abc satter machine s/n 075-01-1069 etc for further chattels please see schedule attatched to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account assignment
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 08 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of lease agreements
    Brevi particolari
    All moneys from time to time credited and for the time being standing to the credit of account 30608963 with barclays bank PLC together with all debts represented thereby the cash collateral account and such other assets.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units BT200/2 3 and 5 solway industrial estate maryport allerdale cumbria.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 21 ago 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 nov 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 lug 1997
    Consegnato il 04 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 set 2012Fine dell'amministrazione
    05 dic 2011Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert James Hebenton
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    2
    DataTipo
    14 set 2012Inizio della liquidazione
    11 giu 2016Data di scioglimento
    13 gen 2016Conclusione della liquidazione
    07 set 2012Data della petizione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert James Hebenton
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Toby Scott Underwood
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0