ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03279316 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1st Floor 30 Cannon Street EC4M 6YN London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INHOCO 570 LIMITED | 15 nov 1996 | 15 nov 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd a 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN in data 30 mag 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Mary Jane Vickery come segretario in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Karen Anita Prins il 09 nov 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Mary Jane Vickery come amministratore in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2017 al 31 mar 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Dr Karen Anita Prins come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jill Margaret Watts come amministratore in data 30 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Henry Jonathan Davies come amministratore in data 01 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Catherine Mary Jane Vickery come amministratore in data 01 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Craig Barry Lovelace come amministratore in data 30 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jill Margaret Watts come amministratore in data 17 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen John Collier come amministratore in data 16 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Henry Jonathan | Amministratore | 30 Cannon Street EC4M 6YN London 1st Floor England | England | British | 201206200001 | |||||
| PRINS, Karen Anita, Dr | Amministratore | 30 Cannon Street EC4M 6YN London 1st Floor England | England | South African | 238969330004 | |||||
| DAY, Jonathan | Segretario | 19 Kenwood Road Highgate N6 4EA London | British | 122061300001 | ||||||
| RICHARDSON, Ian Ashley | Segretario | Monkswell The Ridgeway EN6 4BH Northaw Hertfordshire | British | 66535330002 | ||||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Segretario | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | 157319350001 | |||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| AINLEY, Harvey Bertenshaw | Amministratore | Priory Road SL5 8EB Ascot Orchard House Berkshire United Kingdom | England | British | 134262810002 | |||||
| BUCKLEY, Fiona Marie | Amministratore | Browning House 14 Barry Rise WA14 3JS Bowdon Cheshire | United Kingdom | British | 61688100004 | |||||
| COLLIER, Stephen John | Amministratore | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | United Kingdom | British | 18350160001 | |||||
| HEMMING, Eric Rodney | Amministratore | The Elms 4 Clifton Drive FY8 5PP Lytham St. Annes Lancashire | British | 84030950001 | ||||||
| ISHAK HANNA, Magdy Adib, Dr | Amministratore | Eliot House 40 Bishops Avenue Hampstead N2 0BA London | England | British | 76628190003 | |||||
| LOVELACE, Craig Barry | Amministratore | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | England | British | 198852370001 | |||||
| RAMSAY, James | Amministratore | The Old Post Office Village Road Dorney SL4 6QW Windsor Berkshire | British | 40105120004 | ||||||
| RICHARDSON, Ian Ashley | Amministratore | Monkswell The Ridgeway EN6 4BH Northaw Hertfordshire | England | British | 66535330002 | |||||
| ROBERTSON, Nigel Mark Inches | Amministratore | Sopworth SN14 6PT Chippenham Wookeys Barn Wiltshire United Kingdom | England | British | 97170790002 | |||||
| SMITH, Michael John | Amministratore | 11 Lower Park Road IG10 4NB Loughton Essex | England | British | 641150001 | |||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Amministratore | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | United Kingdom | British | 102009810003 | |||||
| WATTS, Jill Margaret | Amministratore | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | England | British | 187252950001 | |||||
| WIELAND, Phil | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | England | British | 119448000002 | |||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Hospitals (Property) Limited | 06 apr 2016 | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 14 apr 2005 Consegnato il 29 apr 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 giu 2002 Consegnato il 05 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 giu 2002 Consegnato il 27 giu 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that leasehold property known as land lying to the south of dalton lane barrow-in-furness LA14 4LF t/n CU88004. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 gen 2002 Consegnato il 01 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed to a legal charge dated 7TH march 1997 | Creato il 25 set 1998 Consegnato il 30 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in relation to the company in a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 and made between inhoco 588 limited,abbey hospitals limited,inhoco 575 limited,the company and hsbc equity limited,as amended by a supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998 (as defined) | |
Brevi particolari L/Hold property at barrow,cumbria; t/no cu 88004. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 | Creato il 25 set 1998 Consegnato il 30 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the loan notes (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 14 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited or any group company as defined to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 14 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a abbey park hospital,dalton lane,barrow in furness,cumbria.t/no.CU88004. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 11 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the loan notes and this charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 11 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee and debenture of even date and this charge | |
Brevi particolari The underlease in the property k/a abbey park hospital dalton lane barrow cumbria t/no CU88004. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0