ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED

ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABBEY PARK HOSPITAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03279316
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor 30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 570 LIMITED15 nov 199615 nov 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd a 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN in data 30 mag 2019

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Catherine Mary Jane Vickery come segretario in data 30 nov 2018

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Karen Anita Prins il 09 nov 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Catherine Mary Jane Vickery come amministratore in data 30 nov 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2017 al 31 mar 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dr Karen Anita Prins come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jill Margaret Watts come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2015

    Stato del capitale al 16 dic 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Henry Jonathan Davies come amministratore in data 01 set 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Catherine Mary Jane Vickery come amministratore in data 01 mag 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Barry Lovelace come amministratore in data 30 apr 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    4 pagineAA

    Nomina di Jill Margaret Watts come amministratore in data 17 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen John Collier come amministratore in data 16 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2014

    Stato del capitale al 24 dic 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Henry Jonathan
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Amministratore
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish201206200001
    PRINS, Karen Anita, Dr
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Amministratore
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandSouth African238969330004
    DAY, Jonathan
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    Segretario
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    British122061300001
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Segretario
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    British66535330002
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Segretario
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    157319350001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134262810002
    BUCKLEY, Fiona Marie
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish61688100004
    COLLIER, Stephen John
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    United KingdomBritish18350160001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Amministratore
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British84030950001
    ISHAK HANNA, Magdy Adib, Dr
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    Amministratore
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    EnglandBritish76628190003
    LOVELACE, Craig Barry
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    EnglandBritish198852370001
    RAMSAY, James
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    British40105120004
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Amministratore
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    EnglandBritish66535330002
    ROBERTSON, Nigel Mark Inches
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish97170790002
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Amministratore
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritish641150001
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United KingdomBritish102009810003
    WATTS, Jill Margaret
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    EnglandBritish187252950001
    WIELAND, Phil
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    Amministratore
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    EnglandBritish119448000002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Abbey Hospitals (Property) Limited
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    06 apr 2016
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione03279311
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 apr 2005
    Consegnato il 29 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ) as Security Trustee for the Secured Parties)(In Such Capacity the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 17 giu 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2002
    Consegnato il 27 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that leasehold property known as land lying to the south of dalton lane barrow-in-furness LA14 4LF t/n CU88004. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 22 gen 2002
    Consegnato il 01 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 01 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to a legal charge dated 7TH march 1997
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 30 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in relation to the company in a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 and made between inhoco 588 limited,abbey hospitals limited,inhoco 575 limited,the company and hsbc equity limited,as amended by a supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998 (as defined)
    Brevi particolari
    L/Hold property at barrow,cumbria; t/no cu 88004.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 30 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 30 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the loan notes (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 30 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited or any group company as defined to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a abbey park hospital,dalton lane,barrow in furness,cumbria.t/no.CU88004.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the loan notes and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee and debenture of even date and this charge
    Brevi particolari
    The underlease in the property k/a abbey park hospital dalton lane barrow cumbria t/no CU88004.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0