CABLE ADNET LIMITED

CABLE ADNET LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCABLE ADNET LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03283202
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CABLE ADNET LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CABLE ADNET LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CABLE ADNET LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHELTRADING 136 LIMITED25 nov 199625 nov 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di CABLE ADNET LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CABLE ADNET LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 ago 2017

    • Capitale: GBP 3
    3 pagineSH01

    legacy

    80 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    85 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 25 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2015

    Stato del capitale al 25 nov 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    legacy

    94 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 25 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 nov 2014

    Stato del capitale al 28 nov 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    legacy

    92 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Cessazione della carica di Caroline Withers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mine Ozkan Hifzi come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Gale come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Robert Dominic Dunn come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 25 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 dic 2013

    Stato del capitale al 05 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    legacy

    97 paginePARENT_ACC

    Chi sono gli amministratori di CABLE ADNET LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151005690001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Segretario
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Segretario
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    QUADRANGLE SECRETARIES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002950001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Segretario
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Amministratore
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Amministratore
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Amministratore
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    REXROTH, Lynn Charles
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    American49075080001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Amministratore
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Amministratore
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    STOORNE INCORPORATIONS LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002940001
    STOORNE SERVICES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002930001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CABLE ADNET LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2982404
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CABLE ADNET LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture dated 26TH september 1998 made between (1)telewest communications networks limited,(1) the original charging subsidiaries (2) the original charging partnerships (3) and the toronto-dominion bank in its capacity as security trustee (4)
    Creato il 26 set 1998
    Consegnato il 08 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to the chargees under or pursuant to the agreement dated 27TH march 1998 and/or the security trust deed and/or all or any of the other security documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto Dominion Bank (In Its Capacity as Security Trustee,Agent and First Beneficiary Under the Terms of the Debenture), the Arrangers and the Banks (or Any of Them).
    Transazioni
    • 08 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 09 apr 1998
    Consegnato il 24 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement and/or the debenture and/or the security trust deed (all as defined)
    Brevi particolari
    First fixed charge over all property vested in the company and the rights,title and/or interest from time to time owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc Wood Gundy PLC,as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0