SDC PROPERTY LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSDC PROPERTY LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 03286165
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SDC PROPERTY LTD?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova SDC PROPERTY LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SDC PROPERTY LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MASTERCALL SERVICES LIMITED18 dic 200318 dic 2003
    STOCKPORT DOCTORS CO-OPERATIVE02 dic 199602 dic 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di SDC PROPERTY LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SDC PROPERTY LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ott 2018

    15 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da International House Pepper Road Hazel Grove Stockport SK7 5BW a Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TA in data 06 nov 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 ott 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2016

    7 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 nov 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da 226-232 Wellington Road South Stockport Cheshire SK2 6NW a International House Pepper Road Hazel Grove Stockport SK7 5BW in data 19 nov 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 nov 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 nov 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed mastercall services LIMITED\certificate issued on 17/06/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name17 giu 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 22 mag 2013

    RES15
    change-of-name17 giu 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Cessazione della carica di \John Mcnamara come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bharatkumar Nanavati come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Downes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Carne come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SDC PROPERTY LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NATHOO, Vijay, Dr
    2 Glenholme Road
    Bramhall
    SK7 2BR Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 Glenholme Road
    Bramhall
    SK7 2BR Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish59325080001
    PARKER, Graham, Dr
    Rose Cottage
    Strines
    SK22 3BA Stockport
    Derbyshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Strines
    SK22 3BA Stockport
    Derbyshire
    United KingdomBritish101741300001
    SMITH, Philip Michael
    Devonshire Park Road
    SK2 6JW Stockport
    22
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Devonshire Park Road
    SK2 6JW Stockport
    22
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish12086210001
    BUCK, Michaela Jane
    26 Oakland Avenue
    Offerton
    SK2 6AY Stockport
    Cheshire
    Segretario
    26 Oakland Avenue
    Offerton
    SK2 6AY Stockport
    Cheshire
    British114035200001
    MEHTA, Satish Chander, Doctor
    6 Highfield Close
    Davenport
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    Segretario
    6 Highfield Close
    Davenport
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    British45575470001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    ADAMS, John Rupert, Dr
    27 Ernest Street
    SK8 1PN Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    27 Ernest Street
    SK8 1PN Cheadle
    Cheshire
    British58964170003
    ALI, Javaid, Dr
    6 Ladythorn Grove
    Bramhall
    SK7 2HD Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    6 Ladythorn Grove
    Bramhall
    SK7 2HD Stockport
    Cheshire
    U.K.British80193600001
    ATKINSON, Deborah, Dr
    Wellington Road South
    SK2 6NW Stockport
    226-232
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Wellington Road South
    SK2 6NW Stockport
    226-232
    Cheshire
    England
    EnglandBritish172599890001
    BERRY, Patricia Margaret, Doctor
    23 Moseley Road
    Cheadle Hulme
    SK8 5HJ Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    23 Moseley Road
    Cheadle Hulme
    SK8 5HJ Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish54632420001
    BINLESS, John Terence, Doctor
    Chapel House Staveley-In-Cartmel
    Newby Bridge
    LA21 8NH Ulverston
    Cumbria
    Amministratore
    Chapel House Staveley-In-Cartmel
    Newby Bridge
    LA21 8NH Ulverston
    Cumbria
    United KingdomBritish2944550001
    BOSTOCK, David, Doctor
    14 Davenport Park Road
    Davenport
    SK2 6JS Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    14 Davenport Park Road
    Davenport
    SK2 6JS Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish6747000001
    BUCK, Michaela Jane
    26 Oakland Avenue
    Offerton
    SK2 6AY Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    26 Oakland Avenue
    Offerton
    SK2 6AY Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish114035200001
    CAHILL, Aubrey
    155 Queens Road
    SK8 5HX Cheadle Hulme
    Cheshire
    Amministratore
    155 Queens Road
    SK8 5HX Cheadle Hulme
    Cheshire
    British101741430001
    CARNE, Peter Rudiger, Dr
    Fulshaw Avenue
    SK9 5JA Wilmslow
    19
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Fulshaw Avenue
    SK9 5JA Wilmslow
    19
    Cheshire
    England
    EnglandBritish156132790001
    DOWNES, Richard Warwick
    Roundcroft
    Romiley
    SK6 4LS Stockport
    37a
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Roundcroft
    Romiley
    SK6 4LS Stockport
    37a
    Cheshire
    England
    EnglandBritish148524200002
    GIBBS, Mary Georgina, Dr
    7 Norman Road
    Rusholme
    M14 5LF Manchester
    Amministratore
    7 Norman Road
    Rusholme
    M14 5LF Manchester
    EnglandBritish96170540001
    GILBERT, David John, Dr
    10 Depleach Road
    SK8 1DZ Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    10 Depleach Road
    SK8 1DZ Cheadle
    Cheshire
    United KingdomBritish50575320001
    HARDMAN, Richard George, Doctor
    Tudor Cottage
    17 Edmonton Road
    SK2 7BG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Tudor Cottage
    17 Edmonton Road
    SK2 7BG Stockport
    Cheshire
    British64438940001
    HUGHES, Claire Margaret, Dr
    32 Hollin Lane
    Styal
    SK9 4JH Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    32 Hollin Lane
    Styal
    SK9 4JH Wilmslow
    Cheshire
    British95175380001
    HUSSAIN, Najabat, Dr
    83 Bridge Lane
    Bramhall
    SK7 3AS Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    83 Bridge Lane
    Bramhall
    SK7 3AS Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish54692500001
    MCNAMARA, John Michael
    143 Manchester Road
    Chapel-En-Le-Frith
    SK23 9TN High Peak
    Windy Haugh
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    143 Manchester Road
    Chapel-En-Le-Frith
    SK23 9TN High Peak
    Windy Haugh
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritish5865750001
    MCNAMARA, John Michael
    Windy Haugh 143 Manchester Road
    Chapel En Le Frith
    SK23 9TN High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    Windy Haugh 143 Manchester Road
    Chapel En Le Frith
    SK23 9TN High Peak
    Derbyshire
    United KingdomBritish5865750001
    MEHTA, Satish Chander, Doctor
    6 Highfield Close
    Davenport
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    6 Highfield Close
    Davenport
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish45575470001
    MOHINDRA, Arun, Dr
    178a Hale Road
    Hale
    WA15 8SQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    178a Hale Road
    Hale
    WA15 8SQ Altrincham
    Cheshire
    British80044960002
    NANAVATI, Bharatkumar, Dr
    60 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HY Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    60 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HY Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish85715440001
    PATEL, Ashwin, Dr
    Charlestown Road West
    Davenport
    SK3 8TW Stockport
    22
    Cheshire
    Amministratore
    Charlestown Road West
    Davenport
    SK3 8TW Stockport
    22
    Cheshire
    EnglandBritish129528840001
    REEVE, Hugh Anthony, Doctor
    28 Amherst Road
    Withington
    M20 4NS Manchester
    Amministratore
    28 Amherst Road
    Withington
    M20 4NS Manchester
    British54632570001
    RILEY, Philip James, Dr
    11 Hardy Drive
    Bramhall
    SK7 2BW Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    11 Hardy Drive
    Bramhall
    SK7 2BW Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish50575360001
    ROBERTS, Anthony
    32 Sevenoaks Avenue
    SK4 4AW Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    32 Sevenoaks Avenue
    SK4 4AW Stockport
    Cheshire
    British84597530001
    ROONEY, Michael Joseph, Dr
    Oaktree Cottage
    3a Flowery Fields Wodsmoor
    SK2 7DR Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Oaktree Cottage
    3a Flowery Fields Wodsmoor
    SK2 7DR Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish74212790001
    SMITH, Philip Michael
    Devonshire Park Road
    Davenport Park
    SK2 6JW Stockport
    22
    Cheshire
    Amministratore
    Devonshire Park Road
    Davenport Park
    SK2 6JW Stockport
    22
    Cheshire
    United KingdomBritish12086210001
    SMITH, Philip Michael
    Devonshire Park Road
    Davenport Park
    SK2 6JW Stockport
    22
    Cheshire
    Amministratore
    Devonshire Park Road
    Davenport Park
    SK2 6JW Stockport
    22
    Cheshire
    United KingdomBritish12086210001
    VELL, Tracey, Doctor
    Bobbins Hall
    Dumbah Lane
    SK10 4EW Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    Bobbins Hall
    Dumbah Lane
    SK10 4EW Prestbury
    Cheshire
    British50385290002
    WALKLEY, Julien Hardie Caton, Dr
    Errwood Road
    Burnage
    M19 2PH Manchester
    34
    England
    Amministratore
    Errwood Road
    Burnage
    M19 2PH Manchester
    34
    England
    EnglandBritish156078750001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SDC PROPERTY LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    25 nov 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    SDC PROPERTY LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 10 feb 2006
    Consegnato il 11 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 232 wellington road south, stockport, cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 2003
    Consegnato il 08 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that freehold property known as 226, 228 and 230 wellington road south and 1 and part of 3 lowfield road, stockport, under t/n's GM351634, GM351635, GM351636, GM333718 and GM877591 and all that leasehold property known as 226, 228 & 232 wellington road south, stockport, t/n GM606845, and each and every part thereof and includes all buildings erected and all equipment fixtures, fittings, plant, machinery, apparatus and materials now or subsequently affixed to or placed on the property.
    Persone aventi diritto
    • Stockport Primary Care Trust
    Transazioni
    • 08 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 lug 2001
    Consegnato il 04 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    226/228/230 (even nos) wellington road south stockport ilowfield road stockport and part of 3 lowfield road stockport greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2001
    Consegnato il 18 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    SDC PROPERTY LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ott 2017Inizio della liquidazione
    11 mar 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steve Markey
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Praticante
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Andrew Poxon
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Praticante
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0