PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPENN HOUSE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03287110
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Dove si trova PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CIVILEMPLOY LIMITED03 dic 199603 dic 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2010

    Stato del capitale al 10 feb 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 03 dic 2009

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 03 dic 2009

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    14 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 30 ott 1997
    Consegnato il 11 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 30 october 1997
    Brevi particolari
    The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. Land an buildings on the south west side of crown street manchester GM52341. L/h land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester LA328553.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 11 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 23 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under or in connection with a sale and purchase agreement dated 23RD december 1996 and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on the south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836; l/h property k/a land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester t/no: LA328553 all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property including any items at the original property; any proceeds of any insurance of the original real property; and a fixed charge over the rental income of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Canada Life Assurance Company
    Transazioni
    • 23 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 09 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any holding or subsidiary company or any other group member to the chargee (as trustee for itself and the other lenders) on any account whatsoever or in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises on the west side of windsor bridge road bath north estate somerset AV81568 somerset hall somerset street bath AV33403 and AV33404 and AV184057 and all buildings and erections and by way of floating charge all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 09 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 04 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a sale and purchase agreement between the company the chargee and estates & general PLC dated 23RD december 1996 on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 13/15 old steine and 1A/1B st. James' street brighton t/n: ESX21909; l/h property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836 and other properties referred to in schedule together with all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, its goodwill and uncalled capital floating charge over the undertaking and property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Canada Life Assurance Company
    Transazioni
    • 04 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0