NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED

NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNHP SECURITIES NO. 3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03287957
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Situations in which directors have or can have a direct or indirect interest that conflicts with interest of the company authorised, notwithstanding that any such conflict may breach director's duty under S175 of CA2006. 25/08/2021
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    22 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 032879570278 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032879570277 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032879570279 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 032879570282, creata il 27 apr 2021

    216 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 032879570280, creata il 27 apr 2021

    57 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 032879570281, creata il 27 apr 2021

    90 pagineMR01

    Nomina di Mr James Walter Tugenhat come amministratore in data 14 set 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di James Justin Hutchens come amministratore in data 05 feb 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    19 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Justin Hutchens il 08 gen 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Chaitanya Bhupendra Patel come amministratore in data 22 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr James Justin Hutchens come amministratore in data 21 set 2017

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 032879570275 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 032879570276 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    EnglandBritish274658560001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Segretario
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    British44830480001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Segretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    KILMARTIN, Adrian Robert
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    Segretario
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    British11660010001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Segretario
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Segretario
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Segretario
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Segretario
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Malaysian140239060001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Segretario
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    English51896650001
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Amministratore
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Amministratore
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BENSON, David Frederick
    24 Middleton Road
    01921 Boxford
    Massachusetts
    Usa
    Amministratore
    24 Middleton Road
    01921 Boxford
    Massachusetts
    Usa
    Usa49415160001
    BERGBAUM, Arthur
    23 Pine Grove
    Totteridge
    N20 8LB London
    Amministratore
    23 Pine Grove
    Totteridge
    N20 8LB London
    British1770100001
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Amministratore
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmerican82685720001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Amministratore
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DAVIES, William Jeremy
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish21505070001
    DRAYTON, James Henry
    29 Salcott Road
    SW11 6DQ London
    Amministratore
    29 Salcott Road
    SW11 6DQ London
    Australian68239480002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Amministratore
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ELLERT, Richard John
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    Amministratore
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    British95944260001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish44830480001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Amministratore
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HARGRAVE, David Grant
    Trench Hill
    Painswick
    GL6 6TZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Trench Hill
    Painswick
    GL6 6TZ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish23603220002
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Amministratore
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    MARSHALL, Diana Jane
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    Amministratore
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    British47799990002
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Amministratore
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Amministratore
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Amministratore
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Nhp Limited
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    01 mag 2017
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione02798607
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    NHP SECURITIES NO. 3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2021
    Consegnato il 29 apr 2021
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 29 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2021
    Consegnato il 27 apr 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 27 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2021
    Consegnato il 27 apr 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 27 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2017
    Consegnato il 10 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 10 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2017
    Consegnato il 06 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 06 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2017
    Consegnato il 05 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 05 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 nov 2014
    Consegnato il 03 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects k/a and forming balfarg kilmichael road glenrothes scotland t/no FFE6226.
    Persone aventi diritto
    • Hcp, Inc
    Transazioni
    • 03 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 nov 2014
    Consegnato il 21 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Ash grove fir tree road hounslow please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hcp. Inc. (As Security Agent)
    Transazioni
    • 21 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 23 february 2007 and
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 07 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a balfarg glenrothes t/no FFE6226, all and whole that area of ground at shore street cambeltown.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse London Branch
    Transazioni
    • 07 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    The standard security
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 01 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects k/a balfarg glenrothes t/no FFE6226 and that plot or area of ground at shore street campbeltown situated in the royal burgh of campbeltown and county of argyll. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse
    Transazioni
    • 01 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security deed
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 30 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 7 potlands leeming bar northallerton t/no NYK125587, f/h property at 48 princess drive york t/no NYK303256. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch
    Transazioni
    • 30 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 21 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land k/a 7 the portlands, leeming bar, northallerton, north yorkshire t/n NYK125587 k/a the portlands the f/h land k/a 48 princess drive, boroughbridge road, york t/n NYK303256 k/a princess drive fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2005
    Consegnato il 20 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. The potlands 7 the potlands leeming bar northallerton north yorkshire t/no NYK125587, princess drive 48 princess drive boroughbridge roard york t/no NYK303256, willoughby close 17 willoughby close old hall warrington t/no CH243077. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 20 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 05 ago 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that f/h property being land adjoining brooklands nursing home, grimsby part t/n HS265060. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 2 june 2005 and
    Creato il 19 mag 2005
    Consegnato il 09 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Properties k/a fairview, bannockburn, barony of lews, ross and cromarty forming part of the croft and lands k/a plasterfield holding, stornoway. Cairnie lodge, arbroath t/no ANG2406. Piece of ground situated in rosskeen, ross and cromarty extending to one hectare and one hundred and ninety one decimal or one thousandth parts of a hectare k/a the walled garden, the house of rosskeen, invergordon, ross-shire. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 09 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 05 april 2004, dated 10 december 2003 and
    Creato il 05 gen 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subjects at kilmichael road, glenrothes, fife t/n ffe 6226.
    Persone aventi diritto
    • The Fife Council
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of operator lease security
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 16 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of all right title and interest to in and under all present and future all rights benefits and title in respect of the operator lease security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 11 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All such f/h interest in the birches nursing home churchfield drive rainworth nottinghamshire t/n NT304592 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery and other immovable property from time to time thereon and ech and every part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 21 gen 2003
    Consegnato il 22 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H interest in 52/54 cannock road chase terrace staffordshire together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery and other immovable property from time to time thereon and each and every part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 22 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 28 ago 2002
    Consegnato il 29 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property by way of first legal mortgage being all such freehold interest in langley park nursing home, front street, langley park, county durham t/n DU192642 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery and other immovable property from time to time thereon and each and every part thereof. All rights and claims to which the company is now or hereafter become entitled in relation to the real property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture under the facility agreement (as defined)
    Creato il 28 nov 2000
    Consegnato il 07 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the guarantee (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 12 ott 2000
    Consegnato il 17 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture dated 11 april 1997) and any further advances made thereunder and pay to the security trustee when due and payable every sum owing,due or incurred by the company to the security trustee or any of the other beneficiaries (as defined) in respect of such liabilities
    Brevi particolari
    Pursuant to the security documents; the freehold interest in sunningdale ii nursing home,dene rd,hexham,northumberland NE46 1HW; part t/no ND82654. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee
    Transazioni
    • 17 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 15 ago 2000
    Consegnato il 17 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined) (including this debenture) provided that there shall be excluded from the foregoing any liability or sum which would, but for this proviso, cause such covenant or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute unlawful financial assistance prohibited by section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries (as Therein Defined))
    Transazioni
    • 17 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 08 mar 2000
    Consegnato il 14 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Brevi particolari
    F/H horsford nursing & residential home,horsbeck way,horsford,norwich,norfolk.t/no.nk 199370 together with all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery and other immovable property from time to time thereon and each and every part thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0