BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED

BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03290520
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SLATERSHELFCO 328 LIMITED11 dic 199611 dic 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT a C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB in data 07 giu 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 apr 2016

    Stato del capitale al 12 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 apr 2015

    Stato del capitale al 09 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2014

    Stato del capitale al 08 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin James Crotty il 28 giu 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Kevin James Crotty come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Oglesby il 31 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Katharine Jane Vokes il 31 mar 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George Oglesby il 31 mar 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* in data 10 mar 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Segretario
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    British96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritish117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Amministratore
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Segretario
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Segretario nominato
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    108 Lorraine Road
    Timperley
    WA15 7QH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    108 Lorraine Road
    Timperley
    WA15 7QH Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish80043450001
    DUNN, Christopher Frank
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    British900005180001
    GRANT, Iain James
    Kiln House Farm
    Luddenden
    HX2 6SU Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiln House Farm
    Luddenden
    HX2 6SU Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritish45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Amministratore
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritish2582690002
    MALIN, Richard William
    21 Molyneux Street
    W1H 5HN London
    Amministratore
    21 Molyneux Street
    W1H 5HN London
    United KingdomBritish48153170001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    YATES, Robert David
    56 Framingham Road
    M33 3RG Sale
    Cheshire
    Amministratore
    56 Framingham Road
    M33 3RG Sale
    Cheshire
    EnglandBritish30535590006

    BRUNTWOOD THIRD PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    B2000 borrower security agreement
    Creato il 06 feb 2007
    Consegnato il 20 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transazioni
    • 20 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 08 gen 1999
    Consegnato il 22 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness monies obligations and liabilities due or to become due from bruntwood estates limited to the chargee (as security trustee for the finance parties (as defined)) or any of them on any account whatsoever under the terms of the credit facility (as defined) and/or in connection with the facility thereby granted and/or under any interest rate swap agreements interest rate cap agreements or other interest rate hedging arrangements of whatsoever nature under the credit facility agreement and/or under the charge together with all expenses (as defined)
    Brevi particolari
    All the income and rights relating thereto from time to time arising or payable to or on behalf of the company in relation to the property and all proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 22 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge and declaration of trust
    Creato il 08 gen 1999
    Consegnato il 22 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties (as defined)) or any of them on any account whatsoever whether or not pursuant to the credit agreement (as defined) or the deed
    Brevi particolari
    All rents licence fees and other like sums payable under each and all of the leases underleases or other occupational interests. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 22 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 gen 1999
    Consegnato il 22 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties (as defined)) or any of them under the terms of the credit facility agreement (as defined) and/or in connection with the facility thereby granted and/or under any interest rate swap agreements interest rate cap agreements or other interest rate hedging arrangements of whatsoever nature in relation to exposure under the credit facility agreement and/or under this charge together with all expenses (as defined)
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south east side of cross street sale greater manchester t/no: GM661725 and all buildings structures and fixtures (including trade fixtures fixed plant and machinery) .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 22 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge and declaration of trust
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 07 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) and to the finance parties or any of them in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    In relation to the property trafford plaza (formerly k/a ashburner house) seymour grove old trafford manchester by way of assignment all rents licence fees and other sums payable under each and all of the leases for full details of charged assets please refer tro form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 07 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 07 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) and to the finance parties or any of them under the terms of a credit facility agreement dtaed 20TH august 1998 and/or in connection with the facility thereby granted and/or under any interest rate swap agreements,interest rate cap agreements or other interest rate hedging arrangements of whatsoever nature
    Brevi particolari
    Property k/a trafford plaza (formerly ashburner house) seymour grove old trafford manchester t/n's LA2300O8,LA228312 and GM138955 and all income and rights relating thereto proceeds of sale or lease all deeds documents and proceeds of insurance. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 07 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 07 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) and to the finance parties or any of them under the terms of a credit facility agreement dtaed 20TH august 1998 and/or in connection with the facility thereby granted and/or under any interest rate swap agreements,interest rate cap agreements or other interest rate hedging arrangements of whatsoever nature
    Brevi particolari
    Property k/a trafford plaza (formerly ashburner house) seymour grove old trafford manchester t/n's LA230008,LA228312 and GM138955 and all income and rights relating thereto any proceeds of sale or lease all deeds documents and all insurance monies relating thereto. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 07 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0