ALBURN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALBURN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03290569
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALBURN LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova ALBURN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KING LOOSE & CO.
    St. John's House 5 South Parade
    OX2 7JL Oxford
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALBURN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per ALBURN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2021, revisionato

    5 pagineAA

    Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2020, revisionato

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2019, revisionato

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2018, revisionato

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bryan William Lawlor il 01 gen 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Santerese Holdings Unlimited Company come persona con controllo significativo il 02 apr 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Livingstone Properties Limited come persona con controllo significativo il 02 apr 2017

    1 paginePSC07

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O King Loose St John's Parade 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL a PO Box OX2 7JL King Loose & Co. St. John's House 5 South Parade Summertown Oxford in data 05 apr 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    14 pagineAA

    Nomina di Alannah Smyth come amministratore in data 21 feb 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2016

    Stato del capitale al 28 apr 2016

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2015

    Stato del capitale al 28 apr 2015

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2014

    Stato del capitale al 28 apr 2014

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bryan Lawlor il 04 ott 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ALBURN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMYTH, Alannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Segretario
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    154678370001
    KINNAIRD, Nigel John
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Amministratore
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Northern IrelandBritish83042830001
    LAWLOR, Bryan William
    Kenilworth Square
    Dublin6
    60
    Ireland
    Amministratore
    Kenilworth Square
    Dublin6
    60
    Ireland
    IrelandIrish154652750015
    SMYTH, Alannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Amministratore
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    IrelandIrish225157700001
    SMYTH, Noel Martin
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    Amministratore
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    IrelandIrish91238420002
    FINNERTY, Pauline
    33 Montrose Close
    IRISH Artane
    Dublin 5
    Ireland
    Segretario
    33 Montrose Close
    IRISH Artane
    Dublin 5
    Ireland
    Irish51685380001
    LAWLOR, Bryan William
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Segretario
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Irish102461750012
    MORAN, John
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Segretario
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Irish81598910001
    SMYTH, Anne Marie
    22 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    Segretario
    22 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    Irish51685600001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    MCKENNA, John
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish116525480001
    MORAN, John
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Amministratore
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Irish81598910001
    SMYTH, Anne Marie
    22 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    Amministratore
    22 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    Irish51685600001
    SMYTH, John Thomas
    New House
    Commons Road
    IRISH Loughlinstown
    Dublin
    Ireland
    Amministratore
    New House
    Commons Road
    IRISH Loughlinstown
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish154904330001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALBURN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Santerese Holdings Unlimited Company
    Leopardstown Office Park
    Sandyford
    2nd Floor, Elm House
    Dublin 18
    Ireland
    02 apr 2017
    Leopardstown Office Park
    Sandyford
    2nd Floor, Elm House
    Dublin 18
    Ireland
    No
    Forma giuridicaUnlimited Company
    Paese di registrazioneRepublic Of Ireland
    Autorità legaleCompanies Act 2014
    Luogo di registrazioneRepublic Of Ireland Register Of Companies
    Numero di registrazione76701
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Burnley Road
    Briercliffe
    BB10 2HG Burnley
    Unit 1 Briercliffe Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Burnley Road
    Briercliffe
    BB10 2HG Burnley
    Unit 1 Briercliffe Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03637472
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ALBURN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 10 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises at 66A eaton sq,london SW1W 9BQ with all fixtures fittings and chattels thereon; the goodwill of business and first fixed charge over all money received; all other payment thereto and all contracts,rights and interest to any proceeds of sale; all rent and other money owing under any occupancy agreements. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 28 giu 2002
    Consegnato il 06 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Freehold property known as 10 eaton gate london SW1M 9BJ t/n NGL756797 and all that freehold property known as 66A eaton square london SW1 t/n NGL756801 and all existing and future fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property situate on or at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over account
    Creato il 04 set 2000
    Consegnato il 12 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to the finance documents
    Brevi particolari
    The amount standing to the credit of the account from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 12 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge by assignment
    Creato il 04 set 2000
    Consegnato il 12 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents
    Brevi particolari
    All title rights and interest in the charged agreements and all benefits to accrue under and/or pursuant to each of the charged agreements (including each instalment of the licence fee and the share of sales proceeds) and the proceeds of any claims damages awards and judgments which may be received under and/or pursuant to the charged agreements and all agreements contracts deeds undertakings guarantees warranties and other documents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 12 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2000
    Consegnato il 08 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings on the north side of causton street london SW1T/n 405967 the f/h land k/a 93 regency street london SW1 tl ngl 774524. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barratt Homes Limited
    Transazioni
    • 08 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge supplemental to a deed of debenture dated 10 april 1997, and a facility agreement dated 4 september 2000
    Creato il 04 set 2000
    Consegnato il 12 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a 93 regency street london t/n NGL774524, all that f/h land with the buildings erected on and k/a 17-37 (odd) causton road vincent street london together with land and buildings t/n 405967 together with all rights and benefits under any agreements, contracts deeds undertakings etc. fixtures fittings plant and machinery, insurances, occupational lease, rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC and Its Successors, Tranferees and Assigns
    Transazioni
    • 12 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge supplemental to a debenture dated 10TH april 1997 and a facility letter dated 10TH may 1999
    Creato il 20 mag 1999
    Consegnato il 09 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    93 regency street london SW1 t/no: NGL12823. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 1997
    Consegnato il 21 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property at 10 eaton gate london SW1, 66A eaton square, london SW1 together with all fixtures fittings and chattels (other than trade machinery), goodwill of any trade or business, interest in any monies received, contracts or agreements. Proceeds of sale of the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 21 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 10 apr 1997
    Consegnato il 24 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage f/h land and buildings 17 to 37 (odd) causton road vincent cottage vincent street together with land and buildings at the back t/n-405967. By way of fixed charge, all f/h or l/h property, all rights, all plant and machinery, goodwill and uncalled capital, book and other debts; by way of first floating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0