ALBURN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ALBURN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03290569 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ALBURN LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova ALBURN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | KING LOOSE & CO. St. John's House 5 South Parade OX2 7JL Oxford England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ALBURN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per ALBURN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2021, revisionato | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2020, revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2019, revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2018, revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bryan William Lawlor il 01 gen 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Santerese Holdings Unlimited Company come persona con controllo significativo il 02 apr 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Livingstone Properties Limited come persona con controllo significativo il 02 apr 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O King Loose St John's Parade 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL a PO Box OX2 7JL King Loose & Co. St. John's House 5 South Parade Summertown Oxford in data 05 apr 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Alannah Smyth come amministratore in data 21 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bryan Lawlor il 04 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ALBURN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMYTH, Alannah | Segretario | Portobello Road Dublin 8 29 Ireland | 154678370001 | |||||||
| KINNAIRD, Nigel John | Amministratore | 14 Magheraconluce Lane BT26 6PT Hillsborough County Down | Northern Ireland | British | 83042830001 | |||||
| LAWLOR, Bryan William | Amministratore | Kenilworth Square Dublin6 60 Ireland | Ireland | Irish | 154652750015 | |||||
| SMYTH, Alannah | Amministratore | Portobello Road Dublin 8 29 Ireland | Ireland | Irish | 225157700001 | |||||
| SMYTH, Noel Martin | Amministratore | 25 Tooting Bec Road SW17 8BY London Flat 7 England | Ireland | Irish | 91238420002 | |||||
| FINNERTY, Pauline | Segretario | 33 Montrose Close IRISH Artane Dublin 5 Ireland | Irish | 51685380001 | ||||||
| LAWLOR, Bryan William | Segretario | Coolamber Court Knocklyon Road 21 Dublin 16 Republic Of Ireland | Irish | 102461750012 | ||||||
| MORAN, John | Segretario | 10 Fitzwilliam Square Dublin Dublin 2 Ireland | Irish | 81598910001 | ||||||
| SMYTH, Anne Marie | Segretario | 22 Fitzwilliam Square IRISH Dublin | Irish | 51685600001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| MCKENNA, John | Amministratore | 34 Brighton Square Rathgar IRISH Dublin 6 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 116525480001 | |||||
| MORAN, John | Amministratore | 10 Fitzwilliam Square Dublin Dublin 2 Ireland | Irish | 81598910001 | ||||||
| SMYTH, Anne Marie | Amministratore | 22 Fitzwilliam Square IRISH Dublin | Irish | 51685600001 | ||||||
| SMYTH, John Thomas | Amministratore | New House Commons Road IRISH Loughlinstown Dublin Ireland | Ireland | Irish | 154904330001 | |||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ALBURN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santerese Holdings Unlimited Company | 02 apr 2017 | Leopardstown Office Park Sandyford 2nd Floor, Elm House Dublin 18 Ireland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Livingstone Properties Limited | 06 apr 2016 | Burnley Road Briercliffe BB10 2HG Burnley Unit 1 Briercliffe Centre Lancashire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ALBURN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 04 apr 2003 Consegnato il 10 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold premises at 66A eaton sq,london SW1W 9BQ with all fixtures fittings and chattels thereon; the goodwill of business and first fixed charge over all money received; all other payment thereto and all contracts,rights and interest to any proceeds of sale; all rent and other money owing under any occupancy agreements. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 28 giu 2002 Consegnato il 06 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Freehold property known as 10 eaton gate london SW1M 9BJ t/n NGL756797 and all that freehold property known as 66A eaton square london SW1 t/n NGL756801 and all existing and future fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property situate on or at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over account | Creato il 04 set 2000 Consegnato il 12 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to the finance documents | |
Brevi particolari The amount standing to the credit of the account from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge by assignment | Creato il 04 set 2000 Consegnato il 12 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents | |
Brevi particolari All title rights and interest in the charged agreements and all benefits to accrue under and/or pursuant to each of the charged agreements (including each instalment of the licence fee and the share of sales proceeds) and the proceeds of any claims damages awards and judgments which may be received under and/or pursuant to the charged agreements and all agreements contracts deeds undertakings guarantees warranties and other documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 04 set 2000 Consegnato il 08 set 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h land and buildings on the north side of causton street london SW1T/n 405967 the f/h land k/a 93 regency street london SW1 tl ngl 774524. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge supplemental to a deed of debenture dated 10 april 1997, and a facility agreement dated 4 september 2000 | Creato il 04 set 2000 Consegnato il 12 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h land k/a 93 regency street london t/n NGL774524, all that f/h land with the buildings erected on and k/a 17-37 (odd) causton road vincent street london together with land and buildings t/n 405967 together with all rights and benefits under any agreements, contracts deeds undertakings etc. fixtures fittings plant and machinery, insurances, occupational lease, rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge supplemental to a debenture dated 10TH april 1997 and a facility letter dated 10TH may 1999 | Creato il 20 mag 1999 Consegnato il 09 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 93 regency street london SW1 t/no: NGL12823. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 nov 1997 Consegnato il 21 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Leasehold property at 10 eaton gate london SW1, 66A eaton square, london SW1 together with all fixtures fittings and chattels (other than trade machinery), goodwill of any trade or business, interest in any monies received, contracts or agreements. Proceeds of sale of the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of debenture | Creato il 10 apr 1997 Consegnato il 24 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985 | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage f/h land and buildings 17 to 37 (odd) causton road vincent cottage vincent street together with land and buildings at the back t/n-405967. By way of fixed charge, all f/h or l/h property, all rights, all plant and machinery, goodwill and uncalled capital, book and other debts; by way of first floating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0