PCV HP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPCV HP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03296331
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PCV HP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PCV HP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PCV HP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP LIMITED24 dic 199624 dic 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di PCV HP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per PCV HP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2018

    6 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2017

    6 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2016

    4 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2015

    4 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 12 apr 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 16 ott 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 set 2014

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 ott 2013

    Stato del capitale al 25 ott 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Nomina di Mr David Leonard Grose come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PCV HP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    Amministratore
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Amministratore
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Segretario
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Amministratore
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Amministratore
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Amministratore
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Amministratore
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Amministratore
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    FP FINANCIAL LDC
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Amministratore
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    49335910001

    PCV HP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 15 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 15 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2001
    Consegnato il 02 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 73 and 75 high street,rhyl title absolute under t/n WA493457 for further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 02 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp limited) each chargor and the security trustee
    Creato il 09 feb 2000
    Consegnato il 21 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transazioni
    • 21 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 giu 1999
    Consegnato il 08 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigned by way of charge all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of: 53 high street newcastle under lyme,64 high street and black swan yard andover,53/55 high street goldaming,2/3 west street farnham,41 fore street trowbridge.for further details of property charged please refer to form 395.other than sums due to the company by way of insurance rent service charge or any vat payable to the company thereon including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security and any proceeds of the forgoing.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 22 giu 1999
    Consegnato il 08 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    53 high street newcastle under lyme-SF260136;53/55 high street godalming-SY287174;2/3 west street farnham-SY149465 and SY494929 for further details of property charged please refer to form 395.together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 12 gen 1999
    Consegnato il 27 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Brevi particolari
    41 fore street trowbridge wiltshire WT145469,11 exchange walk nottingham NT304339,8 high street banbury t/n ON132306 and other properties with all buildings erection fixtures fittings underleases and agreement please refer to form 395 for details of further chrged properties and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Any Other Lender or Any Lender
    Transazioni
    • 27 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 31 ott 1997
    Consegnato il 19 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Brevi particolari
    F/H land being 48/50 south street romford egl 207769 with all buildings erections and fixtures (inc, trade fixtures) fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment and release
    Creato il 31 ott 1997
    Consegnato il 19 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Brevi particolari
    The rents arising in respect of 48/50 south street romford egl 207769.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 17 feb 1997
    Consegnato il 26 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any lender (as defined) or for or in respect of which the company may be liable to the chargee or any lender on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole right title and interest in the assigned rights being all the rights titles benefits and interests of the company to the rents including the rights to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage (General) Limitedas Trustee for Itself and the Other Lenders ("the Trustee")
    Transazioni
    • 26 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The properties being 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over all property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mar 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By clause 2 of the assignment all rights, titles, benefits and interests to all monies incurred to the company under occupational lease/s in respect of 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mar 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 13TH february 1997
    Creato il 03 feb 1997
    Consegnato il 25 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole those shop premises with ancillary storage and office accomodation on basement ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now generally known as numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 25 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PCV HP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 feb 2019Data di scioglimento
    23 set 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0