GNS PROPERTY SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GNS PROPERTY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03296707 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Crown Way NN10 6BS Rushden England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Terry Morris come amministratore in data 01 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 28 feb 2017 al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Dreier come amministratore in data 10 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Dave Lissy come amministratore in data 10 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Elizabeth Boland come amministratore in data 10 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Kramer come segretario in data 10 nov 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr James Walter Tugendhat come amministratore in data 10 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Buckinghamshire HP5 1LH a 2 Crown Way Rushden NN10 6BS in data 14 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adam David Sage come segretario in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Bucks HP5 1SJ England* in data 11 dic 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Segretario | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | 218500000001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Amministratore | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Amministratore | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 211308080001 | |||||
| LISSY, Dave | Amministratore | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 218331690001 | |||||
| TUGENDHAT, James Walter | Amministratore | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United Kingdom | British | 218306870001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| AUGHTERSON, Peter William | Segretario | Farley Hill House Church Lane RG7 1UP Farley Hill Berkshire | British Australian | 37698830004 | ||||||
| BROWNE, Lorna Barrington | Segretario | 26 Hallmead Road SM1 1RP Sutton Surrey | British | 42236390001 | ||||||
| BUXTON-SMITH, Maria Rita | Segretario | 1 Whitsun Pasture Willen Park MK15 9DQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 39442340001 | ||||||
| FAIRHURST, Russell William | Segretario | Flat 1 Elaine Court 123 Haverstock Hill NW3 4RT London | British | 44556020002 | ||||||
| HENDRIE, Neal Malcolm | Segretario | 74 The Drive UB10 8AQ Uxbridge Middlesex | British | 40848270002 | ||||||
| SAGE, Adam David | Segretario | c/o Company Secretary 34 Germain Street HP5 1LH Chesham Asquith House Buckinghamshire United Kingdom | 156315510001 | |||||||
| YARROW, Nicholas John | Segretario | Chiltern View, 27 Cobbetts Ride HP23 4BZ Tring Hertfordshire | British | 127478700001 | ||||||
| AUGHTERSON, Peter William | Amministratore | Farley Hill House Church Lane RG7 1UP Farley Hill Berkshire | British Australian | 37698830004 | ||||||
| CLARKE, James | Amministratore | Jade Place Wendover Road HP17 0TU Butlers Cross Buckinghamshire | British | 84641000001 | ||||||
| COLLETT, Brian | Amministratore | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| FORD, Russell Mark | Amministratore | Elm Field House Moreton OX9 2HS Thame South Oxfordshire | United Kingdom | British | 108597900005 | |||||
| HENDRIE, Neal Malcolm | Amministratore | 74 The Drive UB10 8AQ Uxbridge Middlesex | England | British | 40848270002 | |||||
| MORRIS, Andrew Terry | Amministratore | The Kiln Malthouse Close Ashbury SN6 8LN Swindon Wiltshire | England | British | 123609540001 | |||||
| PHILLIPS, Mark Randall | Amministratore | Scotts Cottage Scots Lane MK18 2HX Adstock Buckinghamshire | United Kingdom | British | 80508130001 | |||||
| PHILPOTT, Stephen John Randall | Amministratore | St John's Cottage Cherry Tree Lane SL3 6JE Fulmer Berkshire | United Kingdom | British | 45243130001 | |||||
| RHODES, Phillip Baverstock | Amministratore | 12 Peterborough Villas SW6 2AT London | United Kingdom | British | 103078920001 | |||||
| RING, Ronald Arthur | Amministratore | 7 Georgian Close Abbeydale GL4 5DG Gloucester Gloucestershire | United Kingdom | British | 52543770001 | |||||
| SAGE, Adam David | Amministratore | Orbital House Park View Road HP4 3EY Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 216961780001 | |||||
| YARROW, Nicholas John | Amministratore | Chiltern View, 27 Cobbetts Ride HP23 4BZ Tring Hertfordshire | England | British | 127478700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asquith Court Holdings Limited | 30 nov 2016 | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
GNS PROPERTY SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 11 giu 2002 Consegnato il 21 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| By a security accession deed between the company, chestnutbay limited (the "parent") and dresdner bank ag, london branch (the "security agent") the company acceded to a debenture dated 10 may 2001, between inter alia, the parent and the security agent | Creato il 10 mag 2001 Consegnato il 23 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies or liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future, including all liabilities in connection with any notes, bills or other instruments accepted by any secured party for or at the request of an obligor and all losses incurred by any secured party in connection therewith (all terms as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 giu 1999 Consegnato il 17 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plot 4, south east of cloverfield hinkley leicestershire t/n LT228396, land on the south of milford road walton on the hill staffordshire t/n SF301213 and land lying to the north of lowry road west ardsley west yorkshire t/n WYK506006. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 giu 1999 Consegnato il 10 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0