GNS PROPERTY SERVICES LIMITED

GNS PROPERTY SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGNS PROPERTY SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03296707
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Andrew Terry Morris come amministratore in data 01 dic 2016

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 28 feb 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2016

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen Dreier come amministratore in data 10 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Dave Lissy come amministratore in data 10 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Elizabeth Boland come amministratore in data 10 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Kramer come segretario in data 10 nov 2016

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr James Walter Tugendhat come amministratore in data 10 nov 2016

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Buckinghamshire HP5 1LH a 2 Crown Way Rushden NN10 6BS in data 14 nov 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Adam David Sage come segretario in data 10 nov 2016

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2015

    Stato del capitale al 04 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2014

    Stato del capitale al 10 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 dic 2013

    Stato del capitale al 27 dic 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Bucks HP5 1SJ England* in data 11 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KRAMER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    218500000001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United StatesAmerican211308080001
    LISSY, Dave
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United StatesAmerican218331690001
    TUGENDHAT, James Walter
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United KingdomBritish218306870001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    AUGHTERSON, Peter William
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    Segretario
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    British Australian37698830004
    BROWNE, Lorna Barrington
    26 Hallmead Road
    SM1 1RP Sutton
    Surrey
    Segretario
    26 Hallmead Road
    SM1 1RP Sutton
    Surrey
    British42236390001
    BUXTON-SMITH, Maria Rita
    1 Whitsun Pasture
    Willen Park
    MK15 9DQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Whitsun Pasture
    Willen Park
    MK15 9DQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British39442340001
    FAIRHURST, Russell William
    Flat 1 Elaine Court
    123 Haverstock Hill
    NW3 4RT London
    Segretario
    Flat 1 Elaine Court
    123 Haverstock Hill
    NW3 4RT London
    British44556020002
    HENDRIE, Neal Malcolm
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    British40848270002
    SAGE, Adam David
    c/o Company Secretary
    34 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Asquith House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Company Secretary
    34 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Asquith House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    156315510001
    YARROW, Nicholas John
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    Segretario
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    British127478700001
    AUGHTERSON, Peter William
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    Amministratore
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    British Australian37698830004
    CLARKE, James
    Jade Place
    Wendover Road
    HP17 0TU Butlers Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Jade Place
    Wendover Road
    HP17 0TU Butlers Cross
    Buckinghamshire
    British84641000001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Amministratore
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    FORD, Russell Mark
    Elm Field House
    Moreton
    OX9 2HS Thame
    South Oxfordshire
    Amministratore
    Elm Field House
    Moreton
    OX9 2HS Thame
    South Oxfordshire
    United KingdomBritish108597900005
    HENDRIE, Neal Malcolm
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritish40848270002
    MORRIS, Andrew Terry
    The Kiln Malthouse Close
    Ashbury
    SN6 8LN Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    The Kiln Malthouse Close
    Ashbury
    SN6 8LN Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish123609540001
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    PHILPOTT, Stephen John Randall
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    Amministratore
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    United KingdomBritish45243130001
    RHODES, Phillip Baverstock
    12 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    Amministratore
    12 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    United KingdomBritish103078920001
    RING, Ronald Arthur
    7 Georgian Close
    Abbeydale
    GL4 5DG Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    7 Georgian Close
    Abbeydale
    GL4 5DG Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish52543770001
    SAGE, Adam David
    Orbital House
    Park View Road
    HP4 3EY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Orbital House
    Park View Road
    HP4 3EY Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish216961780001
    YARROW, Nicholas John
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish127478700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Asquith Court Holdings Limited
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    30 nov 2016
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GNS PROPERTY SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 giu 2002
    Consegnato il 21 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 21 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    By a security accession deed between the company, chestnutbay limited (the "parent") and dresdner bank ag, london branch (the "security agent") the company acceded to a debenture dated 10 may 2001, between inter alia, the parent and the security agent
    Creato il 10 mag 2001
    Consegnato il 23 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies or liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future, including all liabilities in connection with any notes, bills or other instruments accepted by any secured party for or at the request of an obligor and all losses incurred by any secured party in connection therewith (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 23 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 giu 1999
    Consegnato il 17 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 4, south east of cloverfield hinkley leicestershire t/n LT228396, land on the south of milford road walton on the hill staffordshire t/n SF301213 and land lying to the north of lowry road west ardsley west yorkshire t/n WYK506006. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 giu 1999
    Consegnato il 10 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0