SUPERAPPLY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUPERAPPLY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03298186
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUPERAPPLY LIMITED?

    • costruzione di navi e strutture galleggianti (30110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SUPERAPPLY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Asticus Building, 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUPERAPPLY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SUPERAPPLY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Nomina di Mrs Lucy Baird come amministratore in data 16 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lyndsey Pinnington come amministratore in data 16 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2016

    Stato del capitale al 27 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP United Kingdom a Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 27 gen 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Helen Clare Grant come amministratore in data 06 ott 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Gareth Essex Cater il 26 gen 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 30 lug 2015

    1 pagineCH04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 21 st Thomas Street Bristol BS1 6JS a Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP in data 27 mag 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Sanne Group Secretaries (Uk) Limited come segretario in data 26 mag 2015

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 26 mag 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2015

    Stato del capitale al 21 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Stephanie Hopkins come amministratore in data 28 feb 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Ruark come amministratore in data 28 feb 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2014

    Stato del capitale al 08 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gareth Essex Cater il 31 dic 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Helen Clare Grant il 31 dic 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Christopher Ruark come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SUPERAPPLY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    Segretario
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione08334728
    175738460001
    BAIRD, Lucy
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Amministratore
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    JerseyBritish214316900001
    ESSEX CATER, Gareth
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritish91555540002
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    Segretario nominato
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    900008790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CHAPMAN, Julia Anne Jennifer
    Vincent Hall Becquet Vincent
    Trinity
    JE3 5FG Jersey
    Amministratore
    Vincent Hall Becquet Vincent
    Trinity
    JE3 5FG Jersey
    United KingdomBritish51408760001
    DE CARTERET, Simon Boyd
    Key West
    GY9 0SB Sark
    Channel Islands
    Amministratore
    Key West
    GY9 0SB Sark
    Channel Islands
    British9554140001
    GIBSON, Raymond Terry
    Clos De Saignie
    GY9 0SF Sark
    Channel Islands
    Amministratore
    Clos De Saignie
    GY9 0SF Sark
    Channel Islands
    British34437230001
    GRANT, Helen Clare
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Channel Islands
    Channel Islands
    Amministratore
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Channel Islands
    Channel Islands
    British89200070001
    HOPKINS, Stephanie
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Channel Islands
    United Kingdom
    Amministratore
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Channel Islands
    United Kingdom
    United KingdomBritish184031310001
    LE BLANCQ, Daniel
    La Route De Vinchelez
    JE3 2DA St. Oven
    Maison Marguerite
    Jersey
    Amministratore
    La Route De Vinchelez
    JE3 2DA St. Oven
    Maison Marguerite
    Jersey
    British91610960003
    PINNINGTON, Lyndsey
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish184033110001
    RUARK, Christopher
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Channel Islands
    United Kingdom
    Amministratore
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Channel Islands
    United Kingdom
    United KingdomBritish184033120001
    VARDON, Simon
    La Rue D'Elysee
    St. Peter
    JE3 7DT Jersey
    Slieve Gallion
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue D'Elysee
    St. Peter
    JE3 7DT Jersey
    Slieve Gallion
    Channel Isles
    JerseyBritish125740370001
    WARREN, Marisa Joanne
    9 Clarke Avenue
    St Helier
    JE2 3WJ Jersey
    Hillside
    Amministratore
    9 Clarke Avenue
    St Helier
    JE2 3WJ Jersey
    Hillside
    British140878800001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SUPERAPPLY LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    31 dic 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    SUPERAPPLY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 24 ott 2002
    Consegnato il 01 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the account and the deposit by way of first fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 09 set 1999
    Consegnato il 28 set 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a shipbuilding contract dated 15TH september 1997
    Brevi particolari
    A refund guarantee no sy-14161 for the amount of spanish pesetas 500,000,000 issued on the 6TH of september 1999 by caja de ahorros y monte de piedad de madrid in favour of the company as security for the fulfilment of the obligations of the builder in respect of an offshore loading tanker k/a hull no 317 in accordance with the terms of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vi K/S
    Transazioni
    • 28 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 09 set 1999
    Consegnato il 28 set 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a shipbuilding contract dated 15TH september 1997
    Brevi particolari
    A refund guarantee no sy-14151 for the amount of us$16,100,000 issued on the 2ND of september 1999 by caja de ahorros y monte de piedad de madrid in favour of the company as security for the fulfilment of the obligations of the builder in respect of an offshore loading tanker k/a hull no 317 in accordance with the terms of the agreements.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vi K/S
    Transazioni
    • 28 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 23 dic 1998
    Consegnato il 09 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a sales contract dated 25TH september 1997
    Brevi particolari
    A refund guarantee no sy-13801 for the amount of $20,125,000 issued on 23/12/98. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vii K/S
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 25 nov 1998
    Consegnato il 09 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a sales contract dated 25TH september 1997
    Brevi particolari
    A refund guarantee no sy-13749 for the amount of ptas 1,500,000,000 issued on 23/11/98. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vii K/S
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 11 nov 1998
    Consegnato il 09 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a sales contract dated 25TH september 1997
    Brevi particolari
    Refund guarantee no sy-13709 for the amount of $20,125,000 issued on 5/11/98. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vii K/S
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 23 dic 1997
    Consegnato il 09 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a sales contract dated 25TH september 1997
    Brevi particolari
    Refund guarantee no GL0000271 for the amount of $4,025,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vii K/S
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of endorsement
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 09 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a sales contract dated 25TH september 1997
    Brevi particolari
    A refund guarantee no GL0000270 for the amount of us$4,025,000 issued on 3 october 1997. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Knutsen Boyelaster Vii K/S
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0