DC PAYMENTS UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DC PAYMENTS UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03298469 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DC PAYMENTS UK LIMITED?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova DC PAYMENTS UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Trident Place, Building 4, 1st Floor Mosquito Way AL10 9UL Hatfield England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DC PAYMENTS UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INFOCASH LIMITED | 21 mar 2001 | 21 mar 2001 |
| TOUCHSCREEN SYSTEMS LIMITED | 02 gen 1997 | 02 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DC PAYMENTS UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per DC PAYMENTS UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mohammed Dilshad Kasmani come amministratore in data 23 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Marc Christopher Terry come amministratore in data 08 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tim Gibson Wilder come amministratore in data 13 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Valiant House 12 Knoll Rise Orpington Kent BR6 0PG a Trident Place, Building 4, 1st Floor Mosquito Way Hatfield AL10 9UL in data 30 ott 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Patrick William Moriarty come amministratore in data 12 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jana Hile come amministratore in data 12 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Aimie Killeen come segretario in data 06 gen 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Amanda Joanne Gallacher come amministratore in data 06 gen 2017 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey James Smith come amministratore in data 06 gen 2017 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Tim Gibson Wilder come amministratore in data 06 gen 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mohammed Dilshad Kasmani come amministratore in data 06 gen 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Jana Hile come amministratore in data 06 gen 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Angela Denise King come amministratore in data 18 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Amanda Joanne Gallacher come amministratore in data 18 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DC PAYMENTS UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORIARTY, Patrick William | Amministratore | Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Trident Place, Building 4, 1st Floor England | Canada | Australian | 233477700001 | |||||
| TERRY, Marc Christopher | Amministratore | Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Trident Place, Building 4, 1st Floor England | United Kingdom | British | 168462560001 | |||||
| CAMPION, Richard Charles | Segretario | 2 Wares Close Winterborne Kingston DT11 9BS Blandford Forum Dorset | British | 40872370001 | ||||||
| KATHOL, Brian Bernard | Segretario | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent England | 169877510001 | |||||||
| KILLEEN, Aimie | Segretario | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent England | 178736150001 | |||||||
| LOWE, Peter Clive | Segretario | 105 Addison Road BN3 1TS Hove East Sussex | British | 52320250005 | ||||||
| TROPMAN, David Alan | Segretario | Ormond Cottage Ridgley Road Chiddingfold GU8 4QN Godalming Surrey | British | 10354120001 | ||||||
| WILDER, Tim | Segretario | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent England | 149926520001 | |||||||
| WILDER, Tim Gibson | Segretario | The Boathouse Lower Wharf OX10 9AA Wallingford Oxfordshire | British | 81849700001 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| CAMPION, Richard Charles | Amministratore | 2 Wares Close Winterborne Kingston DT11 9BS Blandford Forum Dorset | England | British | 40872370001 | |||||
| CORNELL, Daryl | Amministratore | B Street MS 39560 Long Beach 21405 Mississippi Usa | Usa | American | 134186840003 | |||||
| GALLACHER, Amanda Joanne | Amministratore | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent | Canada | Canadian | 203944210001 | |||||
| HILE, Jana | Amministratore | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent United Kingdom | England | Australian | 192111080001 | |||||
| JOHNSON, William Clarence | Amministratore | 2190 Blackheath Trace Alpharetta Ga 3005 Usa | American | 124259360001 | ||||||
| KASMANI, Mohammed Dilshad | Amministratore | 3250 Briarpark Drive 77042 Houston Suite 400 Texas United States | United States | American | 205984900001 | |||||
| KETT, Brian Jay | Amministratore | 40 Chatham Drive Nw Calgary Alberta T2l 0z5 Canada | Canadian | 114724310001 | ||||||
| KING, Angela Denise | Amministratore | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent England | Canada | Canadian | 169877300001 | |||||
| LETT, Donald | Amministratore | 21405 B Street 39560 Long Beach Triton Systems Ms Usa | Usa | American | 149925670001 | |||||
| LOWE, Peter Clive | Amministratore | 105 Addison Road BN3 1TS Hove East Sussex | British | 52320250005 | ||||||
| ONOLAN, Eamonn Maire | Amministratore | The Bridleway Goring On Thames RG8 0HS Reading Oxon | British | 58607620002 | ||||||
| SMITH, Jeffrey James | Amministratore | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent England | Canada | Canadian | 169876890001 | |||||
| THURTELL, Daniel David | Amministratore | 5003 Oak Court Long Beach Mississippi Ms 39560 U S A | American | 91712640001 | ||||||
| WILDER, Tim Gibson | Amministratore | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent United Kingdom | England | British | 81849700001 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DC PAYMENTS UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infocash Holdings Limited | 06 apr 2016 | 12 Knoll Rise BR6 0PG Orpington Valiant House Kent England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DC PAYMENTS UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 18 dic 2013 Consegnato il 20 dic 2013 | In corso | ||
Breve descrizione None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 ago 2012 Consegnato il 11 set 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 giu 2005 Consegnato il 24 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over fluctuating deposit | Creato il 22 giu 2005 Consegnato il 24 giu 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys held on any current, deposit and/or other account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over fixed deposit | Creato il 22 giu 2005 Consegnato il 24 giu 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys held on any current deposit and/or other account but limited to £100,000.00. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 12 lug 2002 Consegnato il 23 lug 2002 | In corso | Importo garantito £22,500.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The rent deposit deed of £22,500.00 held in an account referred to in the rent deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 11 lug 2000 Consegnato il 21 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0