PII HOLDINGS

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPII HOLDINGS
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 03299008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PII HOLDINGS?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova PII HOLDINGS?

    Indirizzo della sede legale
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Northumberland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PII HOLDINGS?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PII HOLDINGS LIMITED01 ott 199901 ott 1999
    PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL (UK) LIMITED10 ott 199710 ott 1997
    BRITISH GAS UK HOLDINGS LIMITED 13 feb 199713 feb 1997
    BG UK HOLDINGS LIMITED06 gen 199706 gen 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di PII HOLDINGS?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PII HOLDINGS?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 30 giu 2016

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mar 2016

    Stato del capitale al 08 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    That the issued share capital of the company be reduced from £12490679 divided into 12,490,679 ordinary shares of £1 each 07/12/2015
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    22 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Ippolito Boccola come amministratore in data 03 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2015

    Stato del capitale al 05 feb 2015

    • Capitale: GBP 12,490,679
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2014

    Stato del capitale al 04 feb 2014

    • Capitale: GBP 12,490,679
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Oakwood Corporate Secretary Limited il 13 ago 2013

    2 pagineCH04

    Nomina di Ippolito Boccola come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Marco Paparoni come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Nomina di Mr Sanjeet Chadda come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin Johnson il 14 ago 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di PII HOLDINGS?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    BELLAMY, Michael
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritish76315930001
    CHADDA, Sanjeet
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritish116527050002
    JOHNSON, Kevin
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritish171411090001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Segretario
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    GRAHAM, William
    23 Pinegarth
    Darras Hall
    NE20 9LF Ponteland
    Northumberland
    England
    Segretario
    23 Pinegarth
    Darras Hall
    NE20 9LF Ponteland
    Northumberland
    England
    British59156580001
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Segretario
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Segretario
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    HIGGINS, Caroline Patricia
    24 Mayfield Road
    Gosforth
    NE3 4HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    24 Mayfield Road
    Gosforth
    NE3 4HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British32519770002
    THOMAS, Luke
    94 Watcombe Road
    South Norwood
    SE25 4UZ London
    Segretario
    94 Watcombe Road
    South Norwood
    SE25 4UZ London
    British48375440001
    THOMAS, Luke
    94 Watcombe Road
    South Norwood
    SE25 4UZ London
    Segretario
    94 Watcombe Road
    South Norwood
    SE25 4UZ London
    British48375440001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    38545840001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ACKHURST, Trent Braden
    Hollyhurst
    Hepscott
    NE61 6LX Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Hollyhurst
    Hepscott
    NE61 6LX Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish120742460001
    BATHGATE, Adam
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritish124847880001
    BERGER, Christopher Carl
    56 Percy Park
    NE30 4JX Tynemouth
    Tyne & Wear
    Amministratore
    56 Percy Park
    NE30 4JX Tynemouth
    Tyne & Wear
    American122240370001
    BOCCOLA, Ippolito
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    Atley Way
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomItalian180334110001
    BUCCI, John Vincent
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United Kingdom
    American124762710001
    CARTLEDGE, Andrew
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    Amministratore
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    British70072110003
    CHRISTIE, Roderick Angus
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    British82543780001
    CLARK, Alyson Margaret
    13 Heron's Place
    TW7 7BE Old Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    13 Heron's Place
    TW7 7BE Old Isleworth
    Middlesex
    United KingdomBritish56868460002
    COOPER, Malcolm Charles
    5 Dukes Avenue
    Finchley
    N3 2DE London
    Amministratore
    5 Dukes Avenue
    Finchley
    N3 2DE London
    United KingdomBritish67587540001
    DANIELL, Paul Nigel
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    British62463920001
    DIGBY, Mark Damien
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Amministratore
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Irish103125610001
    GRAHAM, William
    The Coach House
    Shortridge Hall
    NE64 0XU Warkworth
    Northumberland
    Amministratore
    The Coach House
    Shortridge Hall
    NE64 0XU Warkworth
    Northumberland
    British59156580005
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    HIGGINS, John Daniel
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    Amministratore
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United KingdomIrish157962910001
    HORNBY, Ian
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    North Nelson Industrial Estate
    NE23 1WW Cramlington
    Atley Way
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritish130519940001
    JACOB, Frances Carol
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    Amministratore
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    British38154840001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Amministratore
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    British106985300001
    LITTLE, Daniel Stephen Paul
    48 Chester Road
    Poynton
    SK12 1HA Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    48 Chester Road
    Poynton
    SK12 1HA Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish229666930001
    MANN, Cynthia Kay
    5302 Cambridge
    Sugar Land
    Texas
    United States
    Amministratore
    5302 Cambridge
    Sugar Land
    Texas
    United States
    American122240470001
    MARKHAM, Una
    18 Howard Road
    RG40 2BX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    18 Howard Road
    RG40 2BX Wokingham
    Berkshire
    British49024710001

    PII HOLDINGS ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share pledge agreement between the company and deutsche bank ag london (the secured party)
    Creato il 09 dic 1999
    Consegnato il 21 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the pledgor (the company) to the secured party in connection with or relating to the facilities agreement (as defined) including without limitation all obligations and liabilities of any kind whatsoever of the pledgor to the secured party in connection with or relating to the guarantee (as defined)
    Brevi particolari
    All of the issued and outstanding capital of pii (canada) limited being two (2) common shares and all dividends whether in shares money or property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 21 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Stock pledge agreement made between the company and deutsche bank ag london
    Creato il 09 dic 1999
    Consegnato il 21 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and covenants to be performed by the pledgor (the company) under a guarantee and debenture dated on or about 24TH november 1999 to guarantee and secure obligations under the facilities agreement and the other loan documents or under the charge
    Brevi particolari
    99.99% of the outstanding shares of stock of pipeline integrity international mexico sa de cv and all dividends cash instruments and other property or proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 21 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge agreement
    Creato il 25 nov 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee
    Brevi particolari
    All its shares as well as further shares and all present and future claims of profit being attributable to the shares.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag Lonodn
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge agreement
    Creato il 24 nov 1999
    Consegnato il 07 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    All of the pledged shares and all cash securities dividends and other property accruing therefrom being all issued and outstanding shares owned by the company in pipeline integrity international inc.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London(The "Secured Party" )
    Transazioni
    • 07 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 nov 1999
    Consegnato il 07 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the senior finance documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London(The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 07 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 feb 1998
    Consegnato il 05 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities on the debenture date or in the future due, owing or incurred to each beneficiary by the company (the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents other than in respect of the acquisition debt; and to each beneficiary other than in respect of the acquisition debt by each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0