PII HOLDINGS
Panoramica
| Nome della società | PII HOLDINGS |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 03299008 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PII HOLDINGS?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova PII HOLDINGS?
| Indirizzo della sede legale | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Northumberland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PII HOLDINGS?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PII HOLDINGS LIMITED | 01 ott 1999 | 01 ott 1999 |
| PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL (UK) LIMITED | 10 ott 1997 | 10 ott 1997 |
| BRITISH GAS UK HOLDINGS LIMITED | 13 feb 1997 | 13 feb 1997 |
| BG UK HOLDINGS LIMITED | 06 gen 1997 | 06 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PII HOLDINGS?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per PII HOLDINGS?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 30 giu 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Cessazione della carica di Ippolito Boccola come amministratore in data 03 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Oakwood Corporate Secretary Limited il 13 ago 2013 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Nomina di Ippolito Boccola come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Marco Paparoni come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sanjeet Chadda come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Kevin Johnson il 14 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PII HOLDINGS?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| BELLAMY, Michael | Amministratore | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 76315930001 | |||||||||
| CHADDA, Sanjeet | Amministratore | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 116527050002 | |||||||||
| JOHNSON, Kevin | Amministratore | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 171411090001 | |||||||||
| CONE, Harry Douglas | Segretario | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||||||
| GRAHAM, William | Segretario | 23 Pinegarth Darras Hall NE20 9LF Ponteland Northumberland England | British | 59156580001 | ||||||||||
| GRIFFIN, John Edward Henry | Segretario | 155 Cannon Lane HA5 1HU Pinner Middlesex | British | 4516200001 | ||||||||||
| GRIFFIN, John Edward Henry | Segretario | 155 Cannon Lane HA5 1HU Pinner Middlesex | British | 4516200001 | ||||||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Segretario | 24 Mayfield Road Gosforth NE3 4HE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 32519770002 | ||||||||||
| THOMAS, Luke | Segretario | 94 Watcombe Road South Norwood SE25 4UZ London | British | 48375440001 | ||||||||||
| THOMAS, Luke | Segretario | 94 Watcombe Road South Norwood SE25 4UZ London | British | 48375440001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||||||
| SISEC LIMITED | Segretario | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 38545840001 | |||||||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
| ACKHURST, Trent Braden | Amministratore | Hollyhurst Hepscott NE61 6LX Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | 120742460001 | |||||||||
| BATHGATE, Adam | Amministratore | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 124847880001 | |||||||||
| BERGER, Christopher Carl | Amministratore | 56 Percy Park NE30 4JX Tynemouth Tyne & Wear | American | 122240370001 | ||||||||||
| BOCCOLA, Ippolito | Amministratore | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions Northumberland United Kingdom | United Kingdom | Italian | 180334110001 | |||||||||
| BUCCI, John Vincent | Amministratore | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | American | 124762710001 | ||||||||||
| CARTLEDGE, Andrew | Amministratore | 30 Trailside Road MA 02493 Weston United States | British | 70072110003 | ||||||||||
| CHRISTIE, Roderick Angus | Amministratore | 14 Oakfield Road SL8 5QN Bourne End Buckinghamshire | British | 82543780001 | ||||||||||
| CLARK, Alyson Margaret | Amministratore | 13 Heron's Place TW7 7BE Old Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | 56868460002 | |||||||||
| COOPER, Malcolm Charles | Amministratore | 5 Dukes Avenue Finchley N3 2DE London | United Kingdom | British | 67587540001 | |||||||||
| DANIELL, Paul Nigel | Amministratore | 7 Lucerne Drive Stadhampton OX44 7QT Oxford Oxfordshire | British | 62463920001 | ||||||||||
| DIGBY, Mark Damien | Amministratore | Calle Valle Del Roncal 71, Las Lomas 28660 Boadilla Del Monte Madrid Spain | Irish | 103125610001 | ||||||||||
| GRAHAM, William | Amministratore | The Coach House Shortridge Hall NE64 0XU Warkworth Northumberland | British | 59156580005 | ||||||||||
| GRIFFIN, John Edward Henry | Amministratore | 155 Cannon Lane HA5 1HU Pinner Middlesex | British | 4516200001 | ||||||||||
| HIGGINS, John Daniel | Amministratore | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland | United Kingdom | Irish | 157962910001 | |||||||||
| HORNBY, Ian | Amministratore | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 130519940001 | |||||||||
| JACOB, Frances Carol | Amministratore | 11 Augustus Court Augustus Road Southfields SW19 6NA London | British | 38154840001 | ||||||||||
| KEENAN, John Joseph | Amministratore | 5 Gresham Road CM14 4HN Brentwood Essex | British | 106985300001 | ||||||||||
| LITTLE, Daniel Stephen Paul | Amministratore | 48 Chester Road Poynton SK12 1HA Stockport Cheshire | England | British | 229666930001 | |||||||||
| MANN, Cynthia Kay | Amministratore | 5302 Cambridge Sugar Land Texas United States | American | 122240470001 | ||||||||||
| MARKHAM, Una | Amministratore | 18 Howard Road RG40 2BX Wokingham Berkshire | British | 49024710001 |
PII HOLDINGS ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Share pledge agreement between the company and deutsche bank ag london (the secured party) | Creato il 09 dic 1999 Consegnato il 21 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities of the pledgor (the company) to the secured party in connection with or relating to the facilities agreement (as defined) including without limitation all obligations and liabilities of any kind whatsoever of the pledgor to the secured party in connection with or relating to the guarantee (as defined) | |
Brevi particolari All of the issued and outstanding capital of pii (canada) limited being two (2) common shares and all dividends whether in shares money or property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Stock pledge agreement made between the company and deutsche bank ag london | Creato il 09 dic 1999 Consegnato il 21 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and covenants to be performed by the pledgor (the company) under a guarantee and debenture dated on or about 24TH november 1999 to guarantee and secure obligations under the facilities agreement and the other loan documents or under the charge | |
Brevi particolari 99.99% of the outstanding shares of stock of pipeline integrity international mexico sa de cv and all dividends cash instruments and other property or proceeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge agreement | Creato il 25 nov 1999 Consegnato il 24 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the obligations due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee | |
Brevi particolari All its shares as well as further shares and all present and future claims of profit being attributable to the shares. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge agreement | Creato il 24 nov 1999 Consegnato il 07 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Brevi particolari All of the pledged shares and all cash securities dividends and other property accruing therefrom being all issued and outstanding shares owned by the company in pipeline integrity international inc.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 24 nov 1999 Consegnato il 07 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the senior finance documents | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 20 feb 1998 Consegnato il 05 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities on the debenture date or in the future due, owing or incurred to each beneficiary by the company (the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents other than in respect of the acquisition debt; and to each beneficiary other than in respect of the acquisition debt by each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0