IOP 03300281 LIMITED

IOP 03300281 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIOP 03300281 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03300281
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IOP 03300281 LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova IOP 03300281 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IOP 03300281 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEER HOLDINGS LIMITED07 lug 199807 lug 1998
    GANBURY LIMITED09 gen 199709 gen 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di IOP 03300281 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per IOP 03300281 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 giu 2021

    9 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA a Victoria Court 17-21 Ashford Road Maidstone ME14 5DA in data 28 nov 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    2 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Martin Brendan Birrane come amministratore in data 09 giu 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione di Martin Brendan Birrane come persona con controllo significativo il 09 giu 2018

    1 paginePSC07

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Howard Dawson il 24 gen 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Peer Suite the Hop Exchange 24 Southwark Street London SE1 1TY a Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA in data 23 mag 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 apr 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed peer holdings LIMITED\certificate issued on 27/10/16
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name27 ott 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 ott 2016

    RES15

    Bilancio redatto al 31 lug 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2016

    Stato del capitale al 15 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di IOP 03300281 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BREEZE, Michael David
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    Segretario
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    181173180001
    BIRRANE, Susan Alice
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    Amministratore
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    GibraltarBritishCo Director7828640008
    BIRRANE-RULE, Amanda
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    Amministratore
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    United KingdomBritishCo Director67689710002
    BREEZE, Michael David
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    Amministratore
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    EnglandBritishSolicitor184073430001
    DAWSON, Howard James
    Snow Hill
    Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    Amministratore
    Snow Hill
    Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    EnglandBritishSurveyor152733740001
    MANDER, Richard Charles
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    Amministratore
    17-21 Ashford Road
    ME14 5DA Maidstone
    Victoria Court
    United KingdomBritishFinance Director55797010002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Segretario
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    British7736140001
    WALLWORK, Paul Antony Hewitt
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Segretario
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    174565940001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BIRRANE, Bridget Kathleen
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Amministratore
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    EnglandBritishSolicitor91838040001
    BIRRANE, Martin Brendan
    Snow Hill
    Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    Amministratore
    Snow Hill
    Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    GibraltarIrishProperty Consultant7736150006
    COUCHMAN, Robert Wilfred
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor159317370002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Amministratore
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant7736140001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IOP 03300281 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Martin Brendan Birrane
    Snow Hill
    Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    06 apr 2016
    Snow Hill
    Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Two Snowhill
    Nazionalità: Irish
    Paese di residenza: Gibraltar
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Peer Group Plc
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    England
    06 apr 2016
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    England
    No
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione1265425
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    IOP 03300281 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 07 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    91 southwark bridge road t/n 226384, 93-95 southwark bridge road t/n SGL280540. By way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Berkeley house,49-53 high st,redhill; SY233181. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 47-49 pomeroy st,london SE14 5BL; TGL231676. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being f/h land and buildings k/a middle entry shopping centre, george street, tamworth t/no SF428814; by way of fixed charge the charged assets the goodwill all rents receivable from any lease granted out of the property or the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being f/h land and buildings being rockwell house, gateway, crewe t/no CH393677; by way of fixed charge the charged assets the goodwill all rents receivable from any lease granted out of the property or the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being l/a land and buildings forming st. Mary's centre, thornbury t/no AV186394; by way of fixed charge the charged assets the goodwill all rents receivable from any lease granted out of the property or the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being f/h land and buildings k/a saxon house, station approach, sunbury t/no SY432619; by way of fixed charge the charged assets the goodwill all rents receivable from any lease granted out of the property or the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being f/h land and buildings k/a mace industrial estate, mace lane, ashford t/nos K253827 and K307368; by way of fixed charge the charged assets the goodwill all rents receivable from any lease granted out of the property or the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being l/h land and buildings k/a pemberton house, stafford court, telford t/no SL90860; by way of fixed charge the charged assets the goodwill all rents receivable from any lease granted out of the property or the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1997
    Consegnato il 08 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory and land in glebe road off st peter's road huntingdon cambridgeshire- now k/a unit 12 glebe road.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 24 set 1997
    Consegnato il 02 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking,property and assets of the company,whatsoever and wheresoever,present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    IOP 03300281 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 apr 2017Inizio della liquidazione
    07 mag 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Paul Dante
    Macintyre Hudson Llp Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    Praticante
    Macintyre Hudson Llp Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    Malcolm Cohen
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    James Alexander Snowdon
    6th Floor 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Praticante
    6th Floor 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0